BALFOR MEDICAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBALFOR MEDICAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03408741
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cavendish House Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BALFOR RECRUITMENT GROUP LIMITED06 juin 200006 juin 2000
    BALFOR RECRUITMENT PARTNERSHIP LIMITED24 juil. 199724 juil. 1997

    Quels sont les derniers comptes de BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Allied Healthcare Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de John Henry Whitehead en tant que directeur le 05 juin 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Carl Michael Brown en tant qu'administrateur le 05 juin 2017

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Pethick en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Victoria Haynes en tant que secrétaire le 01 déc. 2015

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE à Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX le 03 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Timothy Mark Pethick en tant qu'administrateur le 09 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Darryn Stanley Gibson en tant que directeur le 09 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Henry Whitehead le 01 mars 2014

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juil. 2015

    État du capital au 24 juil. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2014

    État du capital au 20 août 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Victoria Haynes en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Taguma Ngondonga en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Henry Whitehead en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2013

    État du capital au 05 août 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Qui sont les dirigeants de BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWN, Carl Michael
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    Administrateur
    Lakpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant232841280001
    DAVIES, John
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Enbrook Park
    Sandgate High Street Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    2
    Kent
    United Kingdom
    166680870001
    HAYNES, Victoria
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Secrétaire
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    British182412280001
    HOSKINS, Julie Ann
    118 Ashbrook Road
    B30 2XB Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    118 Ashbrook Road
    B30 2XB Birmingham
    West Midlands
    BritishRecruitment Consultant70842240001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    BritishDirector69603410001
    NGONDONGA, Taguma
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Basing View
    RG21 4EA Basingstoke
    Fanum House
    Hampshire
    United Kingdom
    171613690001
    SAUNDERS, Graham Howard
    18 Woodleigh Avenue
    B17 0NJ Harborne
    West Midlands
    Secrétaire
    18 Woodleigh Avenue
    B17 0NJ Harborne
    West Midlands
    BritishRecruitment Consultant54078770001
    WESTWOOD, Philip John
    Stone Business Park
    Stone
    ST15 0TL Staffordshire
    Secrétaire
    Stone Business Park
    Stone
    ST15 0TL Staffordshire
    BritishAccountant71727490001
    DMCS SECRETARIES LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Secrétaire désigné
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900006030001
    BAL, Jasvinder Singh
    22 Highgate Avenue
    WS1 3BH Walsall
    West Midlands
    Administrateur
    22 Highgate Avenue
    WS1 3BH Walsall
    West Midlands
    EnglandBritishRecruitment Consultant54078740002
    BATEMAN, Stephen John
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishSupport Director133761180001
    ELLIS, Martyn Anthony
    c/o C/O Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o C/O Saga Healthcare
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield Court
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director95749550002
    FISHER, Amanda Lucia
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Rowans
    Merretts Orchard
    GL2 7DS Sumbridge
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector174485990001
    FORBES, Neil
    Brantwood 24 Kaffir Road
    Edgerton
    HD2 2AN Huddersfield
    Administrateur
    Brantwood 24 Kaffir Road
    Edgerton
    HD2 2AN Huddersfield
    BritishRecruitment Consultant70842200002
    GIBSON, Darryn Stanley
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomNew ZealanderCompany Director177930490001
    JOHNSON, David Ian
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    6 Mill Farm Court
    Chebsey
    ST21 6HZ Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector46008570001
    MOFFATT, David Stewart
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    Administrateur
    2 Lawrence Gardens
    Mill Hill
    NW7 4JT London
    EnglandBritishAccountant88747420001
    MURPHY, Charles Furber
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    8 Tidwells Lea
    Warfield
    RG42 3TP Bracknell
    Berkshire
    BritishCompany Director69603410001
    PETHICK, Timothy Mark
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Sandgate
    CT20 3SE Folkestone
    Enbrook Park
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director172197670001
    TAYLOR, Kevin Lee
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    8 Fairway
    Trentham
    ST4 8AS Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector111440290001
    WESTON, Paul David James
    Stone Business Park
    Stone
    ST15 0TL Staffordshire
    Administrateur
    Stone Business Park
    Stone
    ST15 0TL Staffordshire
    United KingdomBritishFinance Director61904620002
    WHITEHEAD, John Henry
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Beaconsfield Road
    AL10 8HU Hatfield
    Beaconsfield House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant182872850002
    DMCS DIRECTORS LIMITED
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    Administrateur désigné
    7 Leonard Street
    EC2A 4AQ London
    900004430001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Allied Healthcare Holdings Limited
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    06 avr. 2016
    Lakhpur Court
    Staffordshire Technology Park
    ST18 0FX Stafford
    Cavendish House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House England And Wales
    Numéro d'enregistrement3370146
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BALFOR MEDICAL LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    24 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    BALFOR MEDICAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating security document
    Créé le 19 juil. 2004
    Livré le 28 juil. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 28 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    A debenture executed in respect of a £10,000,000 mezzanine facility agreement and dated 15TH june 2001 and made between balfour recruitment group limited and barclays bank PLC
    Créé le 02 août 2001
    Livré le 09 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets: the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries on The
    Transactions
    • 09 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A debenture executed in respect of a £45,500,000 senior facility agreement and dated 15TH june 2001 and made between balfour recruitment group limited and barclays bank PLC
    Créé le 02 août 2001
    Livré le 09 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brèves mentions
    All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets: the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries on Theterms and Conditions Set Out in the Intercreditor Deed
    Transactions
    • 09 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 août 2000
    Livré le 21 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts (purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement) which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 21 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 déc. 1999
    Livré le 24 déc. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed
    Brèves mentions
    34 harbourne road edgbaston birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Sir Euan Hamilton Anstruther-Gough Calthorpe and Others
    Transactions
    • 24 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 déc. 1997
    Livré le 17 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all book and other debts present and future and the benefits of all contracts and policies of insurance in relation thereof and first floating charge all undertaking property and assets and rights of the company including assets charged by fixed charge shall for any reason be ineffective.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 17 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0