BALFOR MEDICAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BALFOR MEDICAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03408741 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Adresse du siège social | Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Allied Healthcare Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Henry Whitehead en tant que directeur le 05 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Carl Michael Brown en tant qu'administrateur le 05 juin 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Mark Pethick en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 janv. 2016 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Victoria Haynes en tant que secrétaire le 01 déc. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Enbrook Park Sandgate Folkestone Kent CT20 3SE à Cavendish House Lakpur Court Staffordshire Technology Park Stafford ST18 0FX le 03 déc. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy Mark Pethick en tant qu'administrateur le 09 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Darryn Stanley Gibson en tant que directeur le 09 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Henry Whitehead le 01 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Victoria Haynes en tant que secrétaire | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Taguma Ngondonga en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr John Henry Whitehead en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Carl Michael | Administrateur | Lakpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House United Kingdom | England | British | Accountant | 232841280001 | ||||
DAVIES, John | Secrétaire | Enbrook Park Sandgate High Street Sandgate CT20 3SE Folkestone 2 Kent United Kingdom | 166680870001 | |||||||
HAYNES, Victoria | Secrétaire | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
HOSKINS, Julie Ann | Secrétaire | 118 Ashbrook Road B30 2XB Birmingham West Midlands | British | Recruitment Consultant | 70842240001 | |||||
MURPHY, Charles Furber | Secrétaire | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | Director | 69603410001 | |||||
NGONDONGA, Taguma | Secrétaire | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171613690001 | |||||||
SAUNDERS, Graham Howard | Secrétaire | 18 Woodleigh Avenue B17 0NJ Harborne West Midlands | British | Recruitment Consultant | 54078770001 | |||||
WESTWOOD, Philip John | Secrétaire | Stone Business Park Stone ST15 0TL Staffordshire | British | Accountant | 71727490001 | |||||
DMCS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900006030001 | |||||||
BAL, Jasvinder Singh | Administrateur | 22 Highgate Avenue WS1 3BH Walsall West Midlands | England | British | Recruitment Consultant | 54078740002 | ||||
BATEMAN, Stephen John | Administrateur | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | England | British | Support Director | 133761180001 | ||||
ELLIS, Martyn Anthony | Administrateur | c/o C/O Saga Healthcare Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield Court Hertfordshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 95749550002 | ||||
FISHER, Amanda Lucia | Administrateur | The Rowans Merretts Orchard GL2 7DS Sumbridge Gloucestershire | England | British | Director | 174485990001 | ||||
FORBES, Neil | Administrateur | Brantwood 24 Kaffir Road Edgerton HD2 2AN Huddersfield | British | Recruitment Consultant | 70842200002 | |||||
GIBSON, Darryn Stanley | Administrateur | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | New Zealander | Company Director | 177930490001 | ||||
JOHNSON, David Ian | Administrateur | 6 Mill Farm Court Chebsey ST21 6HZ Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 46008570001 | ||||
MOFFATT, David Stewart | Administrateur | 2 Lawrence Gardens Mill Hill NW7 4JT London | England | British | Accountant | 88747420001 | ||||
MURPHY, Charles Furber | Administrateur | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | Company Director | 69603410001 | |||||
PETHICK, Timothy Mark | Administrateur | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 172197670001 | ||||
TAYLOR, Kevin Lee | Administrateur | 8 Fairway Trentham ST4 8AS Stoke On Trent Staffordshire | England | British | Director | 111440290001 | ||||
WESTON, Paul David James | Administrateur | Stone Business Park Stone ST15 0TL Staffordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 61904620002 | ||||
WHITEHEAD, John Henry | Administrateur | Beaconsfield Road AL10 8HU Hatfield Beaconsfield House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 182872850002 | ||||
DMCS DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 7 Leonard Street EC2A 4AQ London | 900004430001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allied Healthcare Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Lakhpur Court Staffordshire Technology Park ST18 0FX Stafford Cavendish House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BALFOR MEDICAL LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
24 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
BALFOR MEDICAL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Floating security document | Créé le 19 juil. 2004 Livré le 28 juil. 2004 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A debenture executed in respect of a £10,000,000 mezzanine facility agreement and dated 15TH june 2001 and made between balfour recruitment group limited and barclays bank PLC | Créé le 02 août 2001 Livré le 09 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (including the debenture) | |
Brèves mentions All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets: the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A debenture executed in respect of a £45,500,000 senior facility agreement and dated 15TH june 2001 and made between balfour recruitment group limited and barclays bank PLC | Créé le 02 août 2001 Livré le 09 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations due or to become due from the obligor (as defined) to the chargee under or pursuant to the finance documents (including the debenture) | |
Brèves mentions All the company's right title and interest from time to time in and to each of the following assets: the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 18 août 2000 Livré le 21 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge all debts (purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement) which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 15 déc. 1999 Livré le 24 déc. 1999 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed | |
Brèves mentions 34 harbourne road edgbaston birmingham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 déc. 1997 Livré le 17 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on all book and other debts present and future and the benefits of all contracts and policies of insurance in relation thereof and first floating charge all undertaking property and assets and rights of the company including assets charged by fixed charge shall for any reason be ineffective. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0