REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03410223 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Adresse du siège social | Central House Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
État du capital au 09 déc. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Dean Anthony Barber en tant que directeur le 03 avr. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dean Anthony Barber le 02 sept. 2019 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Dean Anthony Barber en tant qu'administrateur le 02 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Brotherton en tant que secrétaire le 03 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Harneet Jagpal en tant que secrétaire le 03 sept. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Redcentric Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mars 2018 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Fraser St John Fisher en tant que directeur le 20 oct. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Peter James Brotherton en tant qu'administrateur le 28 nov. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Peter Brotherton en tant que secrétaire le 28 nov. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGPAL, Harneet | Secrétaire | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 250197100001 | |||||||
BROTHERTON, Peter James | Administrateur | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 116701310002 | ||||
BROTHERTON, Peter | Secrétaire | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 222049800001 | |||||||
COLEMAN, Timothy James | Secrétaire | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 210014220001 | |||||||
CROFT, Estelle Louise | Secrétaire | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | 195008140001 | |||||||
HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 162493770001 | |||||||
HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
HWUVEL, Christopher Edward Francis Van Den | Secrétaire | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 114731960001 | ||||||
MYHILL, Paul Harvey | Secrétaire | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | 175307710001 | |||||||
O'RORKE, Nicholas | Secrétaire | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | 149400410001 | |||||||
STIGWOOD, Roland Francis Wayne | Secrétaire | 23 Brookfield Loggerheads TF9 4RW Market Drayton Salop | British | Director | 46778900001 | |||||
TUNSTALL, Nicholas Paul | Secrétaire | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | British | 57548240002 | ||||||
BALAAM, Martin Anthony | Administrateur | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | Director | 82233550001 | ||||
BARBER, Dean Anthony | Administrateur | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Chief Financial Officer | 230739040001 | ||||
COLEMAN, Timothy James | Administrateur | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | Director | 163698620001 | ||||
FISHER, Fraser St John | Administrateur | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire | England | British | Director | 201664700001 | ||||
HALLETT, Peter John | Administrateur | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | United Kingdom | British | Cfo | 20621770002 | ||||
HALLETT, Peter John | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | Cfo | 20621770002 | ||||
PERKS, Timothy Howard | Administrateur | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | Finance Director | 100207880001 | ||||
STIGWOOD, Roland Francis Wayne | Administrateur | 23 Brookfield Loggerheads TF9 4RW Market Drayton Salop | British | Director | 46778900001 | |||||
TUNSTALL, Lynn | Administrateur | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | England | British | Bookeeper | 53939130002 | ||||
TUNSTALL, Nicholas Paul | Administrateur | Ewelme 11 Park Drive ST4 8AB Trentham Stoke On Trent | United Kingdom | British | Managing Director | 57548240002 | ||||
WEAVER, Anthony Charles | Administrateur | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House North Yorkshire England | United Kingdom | British | It Services Consultant And Company Director | 153397180001 | ||||
YAPP, Stephen | Administrateur | Kirtlington Business Centre Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B Office 10 Oxfordshire | England | British | Chairman | 42686850001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redcentric Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Beckwith Knowle HG3 1UG Harrogate Central House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
06 juil. 2016 | 06 juil. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 01 avr. 2015 Livré le 08 avr. 2015 | En cours | ||
Brève description Lease over first and second floor, griffin house, ludgate hill, birmingham. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 05 déc. 2013 Livré le 12 déc. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 08 avr. 2013 Livré le 11 avr. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Group debenture | Créé le 21 juin 2012 Livré le 29 juin 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 01 oct. 2006 Livré le 13 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 29 juil. 2004 Livré le 05 août 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge all specified debts and other debts. By way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 28 janv. 2000 Livré le 03 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture deed | Créé le 15 déc. 1998 Livré le 19 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0