REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03410223
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Central House
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REDSTONE MANAGED SOLUTIONS LIMITED07 nov. 200707 nov. 2007
    TOLERANT SYSTEMS LTD28 juil. 199728 juil. 1997

    Quels sont les derniers comptes de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    État du capital au 09 déc. 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account be cancelled 18/11/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2020

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Dean Anthony Barber en tant que directeur le 03 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Dean Anthony Barber le 02 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Dean Anthony Barber en tant qu'administrateur le 02 sept. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2019

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Brotherton en tant que secrétaire le 03 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Harneet Jagpal en tant que secrétaire le 03 sept. 2018

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Redcentric Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 27 mars 2018

    2 pagesPSC09

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Fraser St John Fisher en tant que directeur le 20 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 06 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Peter James Brotherton en tant qu'administrateur le 28 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Peter Brotherton en tant que secrétaire le 28 nov. 2016

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAGPAL, Harneet
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    250197100001
    BROTHERTON, Peter James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant116701310002
    BROTHERTON, Peter
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    222049800001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    210014220001
    CROFT, Estelle Louise
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    195008140001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    162493770001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HWUVEL, Christopher Edward Francis Van Den
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British114731960001
    MYHILL, Paul Harvey
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Secrétaire
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    175307710001
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    149400410001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Secrétaire
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    BritishDirector46778900001
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Secrétaire
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    British57548240002
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector82233550001
    BARBER, Dean Anthony
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritishChief Financial Officer230739040001
    COLEMAN, Timothy James
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritishDirector163698620001
    FISHER, Fraser St John
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector201664700001
    HALLETT, Peter John
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Administrateur
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCfo20621770002
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCfo20621770002
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director100207880001
    STIGWOOD, Roland Francis Wayne
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    Administrateur
    23 Brookfield
    Loggerheads
    TF9 4RW Market Drayton
    Salop
    BritishDirector46778900001
    TUNSTALL, Lynn
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Administrateur
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    EnglandBritishBookeeper53939130002
    TUNSTALL, Nicholas Paul
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    Administrateur
    Ewelme
    11 Park Drive
    ST4 8AB Trentham
    Stoke On Trent
    United KingdomBritishManaging Director57548240002
    WEAVER, Anthony Charles
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    Administrateur
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    North Yorkshire
    England
    United KingdomBritishIt Services Consultant And Company Director153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    Administrateur
    Kirtlington Business Centre Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B Office 10
    Oxfordshire
    EnglandBritishChairman42686850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Redcentric Holdings Limited
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Beckwith Knowle
    HG3 1UG Harrogate
    Central House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006, United Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House, United Kingdom
    Numéro d'enregistrement08399756
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 juil. 201606 juil. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    REDCENTRIC MANAGED SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 avr. 2015
    Livré le 08 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    Lease over first and second floor, griffin house, ludgate hill, birmingham.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 08 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 oct. 2016Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    A registered charge
    Créé le 05 déc. 2013
    Livré le 12 déc. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 08 avr. 2013
    Livré le 11 avr. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 19 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Group debenture
    Créé le 21 juin 2012
    Livré le 29 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 avr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2011Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 11 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 2004
    Livré le 05 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all specified debts and other debts. By way of floating charge the floating assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cattles Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 05 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 03 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 janv. 2000
    Livré le 03 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 15 déc. 1998
    Livré le 19 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0