ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED

ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADDAROOM SELF STORAGE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03411507
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    46 Snake Lane
    Alvechurch
    B48 7NL Birmingham
    Worcestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2015

    6 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2015

    État du capital au 11 août 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 sept. 2014

    État du capital au 01 sept. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Minesh Patel le 21 juil. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Minesh Patel le 21 juil. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 sept. 2013

    État du capital au 13 sept. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Brightwell Grange Britwell Road Burnham Bucks SL1 8DF* le 13 sept. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2011

    5 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul John Digby le 12 nov. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2009

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2007

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Qui sont les dirigeants de ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PATEL, Minesh
    The Groves
    46 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Penthouse
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Groves
    46 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Penthouse
    United Kingdom
    British93268900001
    DIGBY, Paul John
    Huntick Road
    Lytchett Minster
    BH16 6BA Poole
    Kitchermans
    Dorset
    United Kingdom
    Administrateur
    Huntick Road
    Lytchett Minster
    BH16 6BA Poole
    Kitchermans
    Dorset
    United Kingdom
    EnglandBritish106679370002
    PATEL, Minesh
    The Groves
    46 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Penthouse
    United Kingdom
    Administrateur
    The Groves
    46 Station Road
    HP9 1AB Beaconsfield
    Penthouse
    United Kingdom
    EnglandBritish93268900002
    WATSON, Mark
    Mallards
    Gracious Pond Road
    GU24 8EX Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Mallards
    Gracious Pond Road
    GU24 8EX Chobham
    Surrey
    United KingdomBritish76299860001
    CARTWRIGHT, Ian
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    British14004290001
    CARTWRIGHT, Margaret
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    British54140390001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    CARTWRIGHT, Ian
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    British14004290001
    CARTWRIGHT, Margaret
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    British54140390001
    CARTWRIGHT, Margaret
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    Administrateur
    1 Fox Way
    Ewshot
    GU10 5TL Farnham
    Surrey
    British54140390001
    LORD, John Francis
    Broadgate Potkiln Lane
    Jordans
    HP9 2XA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Broadgate Potkiln Lane
    Jordans
    HP9 2XA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish50614950001
    LORD, Lesley
    Broadgates Potkiln Lane
    Jordans
    HP9 2XA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Broadgates Potkiln Lane
    Jordans
    HP9 2XA Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British62267120001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    ADDAROOM SELF STORAGE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 10 janv. 2007
    Livré le 16 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 12 cosgrove way luton bedfordshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 sept. 2006
    Livré le 19 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2005
    Livré le 02 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the principal debtor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • John Lord and Lesley Lord
    Transactions
    • 02 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0