NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED

NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03414161
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    166 Sloane Street
    SW1X 9QF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED04 août 199704 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 déc. 2015

    8 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 03 déc. 2014

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Nicholas John Solt en tant que directeur le 31 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 034141610005 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes complets modifiés jusqu'au 31 déc. 2012

    16 pagesAAMD

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 août 2014

    État du capital au 11 août 2014

    • Capital: GBP 18,100,100
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juil. 2013

    État du capital au 24 juil. 2013

    • Capital: GBP 18,100,100
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en partie

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 034141610005

    25 pagesMR01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed victoria investments (london) LIMITED\certificate issued on 22/01/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name22 janv. 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    10 pagesMG01

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Mr Nicholas John Solt en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Adrian Thomas James Moll en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Ian Edward Baker en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Mary Frances Harnetty en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BAKER, Ian Edward
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    EnglandBritish41589330002
    HARNETTY, Mary Frances
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    United KingdomBritish174630930001
    MOLL, Adrian Thomas James
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    JerseyBritish189667540001
    HARGREAVES, Alison Ann
    49 St Georges Avenue
    N7 0AJ London
    Secrétaire
    49 St Georges Avenue
    N7 0AJ London
    British35895680001
    HINCHLIFFE, Caroline
    Yukon Road
    SW12 9PY London
    31a
    Secrétaire
    Yukon Road
    SW12 9PY London
    31a
    British131590610002
    ROBINSON, Katharine Emma
    Gipsy Hill
    SE19 1QL London
    85a
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gipsy Hill
    SE19 1QL London
    85a
    United Kingdom
    147935610001
    TOLHURST, Caroline Mary
    Flat B
    10 Oxberry Avenue
    SW6 5SS London
    Secrétaire
    Flat B
    10 Oxberry Avenue
    SW6 5SS London
    British65695810004
    WATSON-BROCK, Leonie
    Grosvenor Street
    W1K 3JP London
    70
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grosvenor Street
    W1K 3JP London
    70
    United Kingdom
    153199950001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BEEVOR, Stuart Robert Hartley
    Yorktown
    Burgh Heath Road
    KT17 4LS Epsom
    Surrey
    Administrateur
    Yorktown
    Burgh Heath Road
    KT17 4LS Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish38901650004
    CHRISTIE, Antony
    GL6 8JF Frampton Mansell
    Church Cottage
    Gloucestershire
    England
    Administrateur
    GL6 8JF Frampton Mansell
    Church Cottage
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish208481370001
    COCKBURN, George Ian Macloy
    20 Brokes Crescent
    RH2 9PS Reigate
    Surrey
    Administrateur
    20 Brokes Crescent
    RH2 9PS Reigate
    Surrey
    British58892420001
    DAVIS, Robert Richard
    42 Carnoustie Drive
    MK40 4FF Biddenham
    Bedfordshire
    Administrateur
    42 Carnoustie Drive
    MK40 4FF Biddenham
    Bedfordshire
    EnglandBritish83730570002
    FENN SMITH, Oliver Barry Kemp
    44 Vanderbilt Road
    SW18 3BQ London
    Administrateur
    44 Vanderbilt Road
    SW18 3BQ London
    United KingdomBritish61278680001
    HANDLEY, Richard Simon
    The Linhay
    Ilsington
    TQ13 9RS Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    The Linhay
    Ilsington
    TQ13 9RS Newton Abbot
    Devon
    UkBritish56271160005
    HOWARD, Mervyn
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    Administrateur
    5 Park Avenue South
    N8 8LU London
    United KingdomBritish52891020001
    MALLETT, Richard Brian
    138 South Park Road
    SW19 8TA London
    Administrateur
    138 South Park Road
    SW19 8TA London
    EnglandBritish102822550001
    MILLARD, Christopher
    Grosvenor Street
    W1K 3JP London
    70
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Street
    W1K 3JP London
    70
    United Kingdom
    United KingdomBritish158566160001
    MILNE, Julian Richard, Mr.
    101 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EF London
    Administrateur
    101 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7EF London
    EnglandBritish43003530001
    MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    Administrateur
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish6981200001
    REDMAN, Colin John
    34 Pinewood Close
    Broadbridge Heath
    RH12 3TP Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    34 Pinewood Close
    Broadbridge Heath
    RH12 3TP Horsham
    West Sussex
    British25936060001
    ROWLAND, Scott Mark
    Miller Place
    Gerrards Cross
    SL9 7QQ Buckinghamshire
    11
    United Kingdom
    Administrateur
    Miller Place
    Gerrards Cross
    SL9 7QQ Buckinghamshire
    11
    United Kingdom
    United KingdomBritish123145990002
    SCARLES, Nicholas Richard
    Mills Folly
    Hawthorn Lane
    SL2 3TE Farnham Common
    Berkshire
    Administrateur
    Mills Folly
    Hawthorn Lane
    SL2 3TE Farnham Common
    Berkshire
    British113933450001
    SOLT, Nicholas John
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    Administrateur
    Sloane Street
    SW1X 9QF London
    166
    United Kingdom
    JerseyBritish189667530001
    TITCHEN, Jeremy David Tredennick
    86 Forest Road
    Kew
    TW9 3BZ Richmond
    Surrey
    Administrateur
    86 Forest Road
    Kew
    TW9 3BZ Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish46768400004
    WILLIAMS, Raymond Charles
    5 Weldon Rise
    Loughton Village
    MK5 8BW Milton Keynes
    Administrateur
    5 Weldon Rise
    Loughton Village
    MK5 8BW Milton Keynes
    British45838930003
    WRIGHT, John Garnett
    Christmas House
    5 Stoneham Street Coggeshall
    CO6 1TT Colchester
    Essex
    Administrateur
    Christmas House
    5 Stoneham Street Coggeshall
    CO6 1TT Colchester
    Essex
    British14526100001

    NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 08 mai 2013
    Livré le 16 mai 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    L/H land and property k/a 40 grosvenor place london t/no NGL753206.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Hypothekenbank (Action-Gesellschaft)
    Transactions
    • 16 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 10 janv. 2013
    Livré le 16 janv. 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) (the Agent)
    Transactions
    • 16 janv. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 mai 2013Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 04 nov. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Confirmatory security agreement
    Créé le 19 mars 2012
    Livré le 23 mars 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Almack house 28 king street london t/no NGL769429 all plant and machinery all benefits in respect of the insurances all rental income the partnership agreement floating charge all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Agent) as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 23 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A confirmatory security agreement
    Créé le 14 sept. 2010
    Livré le 21 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Almack house 28 king street london t/no NGL769429 first fixed charge all plant and machinery,all benefits in respect of the insurances,the benefit of all licences,consents and authorizations see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 21 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Security agreement
    Créé le 19 sept. 2005
    Livré le 28 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Almack house 28 king street london t/no NGL769429, 109 to 118 broad street london t/no NGL731926, 40 grosvenor place london t/no NGL753206 and 25 moorgate london t/nos NGL797565 and NGL797368. Its rights under the trust arrangements, all plant and machinery, all benefits in respect of the insurances and claims and rights under each occupational lease. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Agent)
    Transactions
    • 28 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    NPS VICTORIA INVESTMENTS (LONDON) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 déc. 2014Commencement of winding up
    28 oct. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0