BOS PERSONAL LENDING LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BOS PERSONAL LENDING LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03416733 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| Adresse du siège social | Trinity Road Halifax HX1 2RG |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2027 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 janv. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 janv. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 janv. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2025 | 10 pages | AA | ||
Nomination de Mr Praven Subbramoney en tant qu'administrateur le 17 juin 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Hiral Gogoi en tant que directeur le 18 juin 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Alyson Elizabeth Mulholland le 12 mai 2025 | 1 pages | CH03 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 juin 2024 | 15 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2023 au 30 juin 2024 | 1 pages | AA01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 21 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Israel Santos Perez en tant que directeur le 24 févr. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Anish Bipin Ambani en tant qu'administrateur le 01 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Elyn Jane Corfield en tant que directeur le 09 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Hiral Gogoi en tant qu'administrateur le 09 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 23 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Sara Jayne Bayley en tant que directeur le 02 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 23 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Israel Santos Perez le 11 mars 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 janv. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Elyn Jane Corfield en tant qu'administrateur le 09 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom à Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 1 pages | AD02 | ||
Qui sont les dirigeants de BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOLLAND, Alison Elizabeth | Secrétaire | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 238402550002 | |||||||
| AMBANI, Anish Bipin | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 306223830001 | |||||
| SUBBRAMONEY, Praven | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | South African | 337362030001 | |||||
| GITTINS, Paul | Secrétaire | House Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower United Kingdom | 164928190001 | |||||||
| HENNESSEY, David Dermot | Secrétaire | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 196033570001 | |||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secrétaire | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 204723380001 | |||||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Secrétaire | Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st Floor East England England | 190361630001 | |||||||
| LAKIN, Helen Mary | Secrétaire | Gorphwysfa 6 Nant Road Bwlchgwyn LL11 5YN Wrexham Clwyd | British | 41250190001 | ||||||
| LOCKWOOD, Angela | Secrétaire | Lloyds Banking Group Trinity Road HX1 2RG Halifax C/O Retail Company Secretaries United Kingdom | British | 115797910001 | ||||||
| MAYER, Sally | Secrétaire | 48 Prospect Street Shibden Heights HX3 6LG Halifax | British | 75435950002 | ||||||
| MOULTON-BRADY, Steven | Secrétaire | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 183850490001 | |||||||
| NIXON, Raymond | Secrétaire | Holly House The Steadings Wicker Lane, Guilden Sutton CH3 7EL Chester Cheshire | British | 36433110016 | ||||||
| SOBO, Femi | Secrétaire | 5 Carr Bridge View Cookridge LS16 7BR Leeds | British | 55778050002 | ||||||
| AITKEN, Stephen | Administrateur | 4th Floor, Miller Street Tower Miller Street M60 0AL Manchester C/O Secretariat United Kingdom | United Kingdom | British,Australian | 188712540001 | |||||
| BAYLEY, Sara Jayne | Administrateur | Tresillian Terrace CF10 5BH Cardiff St William House United Kingdom | United Kingdom | British | 238307600001 | |||||
| BUCKLEY, Paul | Administrateur | The Orchard Bostock Grange Mews Brick Kiln Lane CW10 9JJ Middlewich | British | 94161290001 | ||||||
| CORFIELD, Elyn Jane | Administrateur | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | United Kingdom | British | 182118580002 | |||||
| CUTBILL, Martin James | Administrateur | 4 Lawnsdale Cuddington CW8 2UT Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 54154380001 | |||||
| DUGGAN, Gary John | Administrateur | 6 Latham Way L63 9NX Spital Wirral | British | 74792420001 | ||||||
| DUGGAN, Gary John | Administrateur | 6 Latham Way L63 9NX Spital Wirral | British | 74792420001 | ||||||
| FACCI, Dominic Jeremy | Administrateur | 1 Cherrywood Crescent B91 3XU Solihull West Midlands | England | British | 110859190001 | |||||
| FOWLER, Louise Helen | Administrateur | 1 Egerton Road Davenport SK3 8SR Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 284520580001 | |||||
| FRANKLIN, Timothy Alan | Administrateur | Wood Lawn Cottage Wood Lane ST14 8JR Uttoxeter Staffordshire | Uttoxeter | British | 82709500001 | |||||
| GALASSI, James Giuliano | Administrateur | Miller Street M60 0AL Manchester Floor 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 192046820001 | |||||
| GARROD, Claire Louise | Administrateur | Bishopsgate EC2M 3YB London 155 United Kingdom | United Kingdom | British | 185920720001 | |||||
| GITTINS, Paul | Administrateur | 5 Hambledon Close Little Sutton L66 4YF South Wirral | British | 45660860002 | ||||||
| GOGOI, Hiral | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | United Kingdom | British | 304121720001 | |||||
| GORDON, Paul Andrew | Administrateur | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 195107520002 | |||||
| GOSLING, Clare Louise | Administrateur | Cis Tower, 18th Floor Miller Street M60 0AL Manchester The Co-Operative Bank England England | United Kingdom | British | 204863170001 | |||||
| GREGORY, Gerald Arthur | Administrateur | Gatepiece House Quarry Bank DE4 3LF Matlock Derbyshire | England | British | 31843730001 | |||||
| GRIFFITHS, Steven Thomas | Administrateur | 1 Deganwy Close CH7 3QB Buckley Flintshire | British | 70889350001 | ||||||
| HAYES, Francis Michael | Administrateur | 42 Eaton Road CW6 0DG Tarporley Cheshire | British | 110859030001 | ||||||
| HILLIARD, Brett Jonathen | Administrateur | Micklegate Mickle Trafford CH2 4TF Chester 2 United Kingdom | England | British | 114396070001 | |||||
| HILLON, James | Administrateur | 2nd Floor Miller Street M60 0AL Manchester Co-Operative Bank United Kingdom | United Kingdom | British | 170882350001 | |||||
| HOSSACK, Ian | Administrateur | 123 Higher Lane WA13 0BU Lymm Cheshire | England | British | 110558740002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BOS PERSONAL LENDING LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Co-Operative Bank P.L.C. | 06 avr. 2016 | 1 Balloon Street M60 4EP Manchester PO BOX 101 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Bank Of Scotland Plc | 06 avr. 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0