CIVICA IT SYSTEMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCIVICA IT SYSTEMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03417245
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SANDERSON SYSTEMS LIMITED01 oct. 199701 oct. 1997
    BROOMCO (1334) LIMITED11 août 199711 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mars 2015

    État du capital au 11 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 mars 2014

    État du capital au 14 mars 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Downing le 04 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Phillip David Rowland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Stoddard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2007

    7 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2006

    7 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CIVICA IT SYSTEMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    British72002400004
    DOWNING, Simon Richard
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Administrateur
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    EnglandBritish95005230002
    ROWLAND, Phillip David
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    Administrateur
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    United KingdomBritish147804610001
    FROST, Adrian David
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74874640001
    NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    Secrétaire
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    British29772430003
    STEWART, Caroline Elizabeth
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    British52912910002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BEER, Peter James
    9 High Ash Crescent
    LS17 8RP Leeds
    Yorkshire
    Administrateur
    9 High Ash Crescent
    LS17 8RP Leeds
    Yorkshire
    EnglandBritish56245440001
    DEWIS, Brian John
    Wychend
    Grange Road
    SL6 9RW Cookham
    Berkshire
    Administrateur
    Wychend
    Grange Road
    SL6 9RW Cookham
    Berkshire
    EnglandBritish30266880002
    HODKINSON, Allan Leslie
    195 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    195 Foley Road West
    Streetly
    B74 3NX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British21839900001
    KENDRICK-ASTLE, Pamela Elizabeth
    105 Brambling,
    Wilnecote
    B77 5PG Tamworth
    Staffordshire
    Administrateur
    105 Brambling,
    Wilnecote
    B77 5PG Tamworth
    Staffordshire
    British65220350001
    NEWNES SMITH, Suzanne Gabrielle
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Woodford Lodge
    Ramsden Road
    GU7 1QE Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish29772430003
    STEWART, Caroline Elizabeth
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    Administrateur
    17 Priest Meadow Close
    Astwood Bank
    B96 6HT Redditch
    Worcestershire
    British52912910002
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish72002400004
    WATSON, David John
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    Administrateur
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    British45073610001
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch
    Créé le 11 juil. 2000
    Livré le 12 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee)
    Créé le 10 mars 2000
    Livré le 21 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    Transactions
    • 21 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 1999
    Livré le 17 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 1997
    Livré le 01 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CIVICA IT SYSTEMS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2015Commencement of winding up
    08 avr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0