GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03418652 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ?
| Adresse du siège social | Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 10 pages | LIQ13 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD England à Frp Advisory Trading Limited Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ le 10 déc. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Vanessa Claire Balshaw en tant que directeur le 04 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Riverbank House 2 Swan Lane London EC4R 3AD | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 juil. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Vanessa Claire Balshaw le 20 avr. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Jane Conway Blakemore en tant que directeur le 12 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Tania Inge Maria Cruickshank en tant que secrétaire le 13 sept. 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Vanessa Claire Balshaw en tant qu'administrateur le 01 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Fiona Jane Conway Blakemore en tant qu'administrateur le 29 mars 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de George Edmund Richard Wood en tant que directeur le 29 mars 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Elizabeth Anne Woods le 22 août 2017 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Spencer Morton en tant que directeur le 30 nov. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Susan Crichton Kilgour en tant qu'administrateur le 30 nov. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 23 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRUICKSHANK, Tania Inge Maria | Secrétaire | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 262588700001 | |||||||||||
| WOODS, Elizabeth Anne | Secrétaire | Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Trading Limited | 185427240002 | |||||||||||
| KILGOUR, Susan Crichton | Administrateur | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 253138710001 | |||||||||
| DANIELS, Lisa Jane | Secrétaire | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | 158116950001 | |||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Secrétaire | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| GUEST, Robert Austin | Secrétaire | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | British | 44314180001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Secrétaire | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Secrétaire | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 73601950001 | ||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Upper Bank Street E14 5JJ London 10 | 139030920001 | |||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Secrétaire | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 2519400001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Secrétaire | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| BALSHAW, Vanessa Claire | Administrateur | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 260166390002 | |||||||||
| BATAILLE, Alain | Administrateur | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 79407390001 | ||||||||||
| BATES, Mikkel Gascoigne | Administrateur | 89 Boyne Road SE13 5AN London | England | British | 57415660001 | |||||||||
| BLAKEMORE, Fiona Jane Conway | Administrateur | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | England | British | 120501860002 | |||||||||
| BUFFET, Alex Jaques Guy | Administrateur | 37 Alexandra Court 171/175 Queensgate SW7 5HQ London | French | 37269510001 | ||||||||||
| FILBY, Simon Edward | Administrateur | 2 Lassa Road Eltham SE9 6PU London | British | 102816560001 | ||||||||||
| FUSCHILLO, Dino | Administrateur | 75 Noel Road N1 8HE London | United Kingdom | British | 56486620002 | |||||||||
| GILMARTIN, Kevan Stuart | Administrateur | Bremhill The Common HP4 2QF Berkhamsted Hertfordshire | British | 92667680001 | ||||||||||
| GREIG, Jonathan | Administrateur | 93 Clarendon Road W11 4JG London | England | British | 141566980001 | |||||||||
| GUEST, Robert Austin | Administrateur | 9 Chisholm Road TW10 6JH Richmond Surrey | Uk | British | 44314180001 | |||||||||
| HILD, Stephane Jean | Administrateur | 47 Onslow Square SW7 3LR London | French | 37800820001 | ||||||||||
| HORLICK, Nicola Karina Christina | Administrateur | 30 Thurloe Square SW7 2SD London | British | 53458480002 | ||||||||||
| IONS, John Stephen | Administrateur | 1 Framfield Road Highbury N5 1UU London | United Kingdom | British | 42905720002 | |||||||||
| JOBBINS, Alison | Administrateur | 14 Ingress Park Avenue DA9 9XJ Greenhithe Kent | British | 120824590001 | ||||||||||
| LAGRANGE, Pierre Philippe Alexandre | Administrateur | Curzon Street W1J 5HB London One United Kingdom | England | Belgian | 161184130001 | |||||||||
| LEEMAN, Matthew | Administrateur | Old Orchard House Harpsden RG9 4AX Henley On Thames | British | 102816450001 | ||||||||||
| MCKELLICK, Christopher James | Administrateur | 51 Harrow Drive RM11 1NT Hornchurch Essex | British | 26238410001 | ||||||||||
| MORTON, John Spencer | Administrateur | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | United Kingdom | British | 73601950003 | |||||||||
| MORTON, John Spencer | Administrateur | Yew Tree Cottage 7-8 Nettleden HP1 3DQ Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 73601950001 | |||||||||
| MURRAY, Malcolm Alexander | Administrateur | 46 Copsem Lane KT10 9HJ Esher Surrey | United Kingdom | British | 31353770002 | |||||||||
| NUSSEIBEH, Saker Anwar, Dr | Administrateur | 21 Palace Gate W8 5LY London | British | 91855640001 | ||||||||||
| O'SULLIVAN, Brian Christopher | Administrateur | 10 Hadley Road EN5 5HH Barnet Hertfordshire | British | 47118120001 | ||||||||||
| PAGNI, Patrick Robert Marie | Administrateur | 24 Thurloe Square SW7 2SD London | French | 33420570003 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glg Partners Uk Group Ltd | 06 avr. 2016 | One Curzon Street W1J 5HB London One Curzon Street England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Créé le 16 mars 2004 Livré le 23 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The equitable interest in the sum of £226,100.00 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 16 mars 2004 Livré le 23 mars 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The sum of £65,887.50 and any other sums paid into that account and any interest credited to that account being a specifically designated deposit account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed | Créé le 27 mars 2002 Livré le 28 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The company's equitable interest in: (a) £65,887.50 to be paid by the company to the landlord no later than 27 march 2003 and which the landlord is obliged under the deed to pay into the account; and (b) any other sums paid into that account by the company pursuant to the deed and any interest credited to that account which has not been released to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 30 juin 2000 Livré le 04 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the above deed | |
Brèves mentions The equitable interest in the securitydeposit. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
GLG PARTNERS UK HOLDINGS LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0