CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03419124 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | CVR GLOBAL LLP Town Wall House Balkerne Hill CO3 3AD Colchester Essex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 13 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 déc. 2021 | 15 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Academy Place 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ England à Town Wall House Balkerne Hill Colchester Essex CO3 3AD le 06 janv. 2021 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 04 nov. 2020
| 5 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 13 août 2020 | 3 pages | RP04CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2020 sans mise à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des détails de Check Safety First Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 24 déc. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des détails de Check Safety First Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 déc. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen David Tate le 17 mars 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 30 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Wine Warehouse, the Back Chepstow Gwent NP16 5HH à Academy Place 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ le 24 déc. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination de Intertek Secretaries Limited en tant que secrétaire le 13 déc. 2019 | 2 pages | AP04 | ||||||||||||||
Nomination de Calin Moldovean en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Julian Burge en tant qu'administrateur le 13 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Alexander Harrington en tant que directeur le 13 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Leslie Thomas Oxley en tant que secrétaire le 13 déc. 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018 | 2 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 août 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTEK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England |
| 174785220001 | ||||||||||
| BURGE, Julian Charles | Administrateur | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | England | British | 193595270001 | |||||||||
| MOLDOVEAN, Calin | Administrateur | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | United States | American | 265575170001 | |||||||||
| TATE, Stephen David | Administrateur | The Wine Warehouse The Back NP16 5HH Chepstow Gwent | Wales | British | 55781510008 | |||||||||
| MITCHELL, Peter James | Secrétaire | 39 Heol Pearetree Rhoose Point CF62 3LB Barry Vale Of Glamorgan | British | 95638810001 | ||||||||||
| OXLEY, Leslie Thomas | Secrétaire | 17 Deans Gardens NP16 5SG Chepstow Monmouthshire | British | 82497600001 | ||||||||||
| SAUNBY, Kevin David | Secrétaire | Rudgwick Westwell Lane Potters Corner TN26 1JA Ashford Kent | British | 18474810005 | ||||||||||
| TATE, Stephen David | Secrétaire | 8 Oakfield Avenue NP16 5NE Chepstow | British | 55781510002 | ||||||||||
| WARHAM, Robert Paul Martin | Secrétaire | 38 Thames Haven 48 Portsmouth Road KT6 4JA Surbiton Surrey | British | 41186820001 | ||||||||||
| KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED | Secrétaire désigné | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004240001 | |||||||||||
| BARNARD, Robert Hugh | Administrateur | Jays Cottage Surrey Gardens Effingham Junction KT24 5HF Leatherhead Surrey | British | 43195270001 | ||||||||||
| BRUCE, Charles | Administrateur | Summerdale 8 Greenway Lane BA2 4LJ Bath | British | 46553680002 | ||||||||||
| BUNGARD, David James | Administrateur | 136 Ruden Way KT17 3LP Epsom Surrey | England | British | 43276900003 | |||||||||
| DELGADO SERRA, Esteban, Senor | Administrateur | C/O Amapolas 38 07193 Palmanyola Bunyola(Baleares) Spain | Spanish | 62283870002 | ||||||||||
| DINSDALE, Norman Humberstone | Administrateur | 15 Donald Woods Gardens Tolworth KT5 9NP Surbiton Surrey | British | 54947300001 | ||||||||||
| GURNEY, Nicholas Graham | Administrateur | Margerywine Cottage Strandon Lane RH5 5QZ Ockley Surrey | British | 42480500003 | ||||||||||
| HARRINGTON, Mark Alexander | Administrateur | Kingsmark House Saint Lawrence Road NP16 6BE Chepstow Monmouthshire | United Kingdom | British | 72386950001 | |||||||||
| HARRIS, David John | Administrateur | Pheasant Pluckers Cottage Threshers Field TN8 7NB Hever Kent | British | 54952300001 | ||||||||||
| RECORD, Anthony | Administrateur | Woodcote House Lodge Lees CT4 6NS Denton Canterbury Kent | British | 31668130001 | ||||||||||
| SLEETH, Alexander | Administrateur | 25 Wychwood Park CW2 5GP Weston Cheshire | Uk | British | 84048730002 | |||||||||
| SMITH, Nigel Stuart | Administrateur | Maidenhead Road Cookham SL6 9DB Maidenhead Berkshire | England | British | 36438630002 | |||||||||
| TATE, Stephen David | Administrateur | 18 Deans Gardens NP6 5SG Chepstow Monmouthshire | British | 55781510001 | ||||||||||
| WARHAM, Robert Paul Martin | Administrateur | 41a Winterdown Road KT10 8LP Esher Surrey | British | 41186820002 | ||||||||||
| KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED | Administrateur désigné | 20 Station Road Radyr CF15 8AA Cardiff | 900004230001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check Safety First Ltd | 06 avr. 2016 | 1-9 Brook Street CM14 5NQ Brentwood Academy Place Essex England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Créé le 27 sept. 2001 Livré le 02 oct. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee,the stockholder (as defined) or either of them under the instrument (as defined) or certificate evidencing the loan stock (as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 27 sept. 2001 Livré le 28 sept. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 21 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or cristal world wide limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CRISTAL INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0