PRESSAC (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPRESSAC (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03420207
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PRESSAC (UK) LIMITED ?

    • (3220) /

    Où se situe PRESSAC (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Glaisdale Drive West
    Bilborough Nottingham
    NG8 4GY Nottinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PRESSAC (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PRESSAC COMMUNICATIONS LIMITED04 juin 200704 juin 2007
    PRESSAC COMMUNICATIONS LIMITED07 oct. 199707 oct. 1997
    PRESSAC LIMITED02 oct. 199702 oct. 1997
    NOTTCOR 47 LIMITED15 août 199715 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de PRESSAC (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PRESSAC (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    19 pagesAA

    legacy

    3 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    24 pagesAA

    Statuts

    8 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed pressac communications LIMITED\certificate issued on 06/06/07
    2 pagesCERTNM

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    22 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2004

    18 pagesAA

    legacy

    7 pages395

    legacy

    11 pages395

    legacy

    7 pages395

    legacy

    3 pages395

    Qui sont les dirigeants de PRESSAC (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURBIDGE, Peter Leslie
    Elm Cottage Gonerby Court
    Gonerby Road
    NG31 8HT Grantham
    Administrateur
    Elm Cottage Gonerby Court
    Gonerby Road
    NG31 8HT Grantham
    United KingdomBritishDirector64511710005
    HOWELL, Colin Anthony
    Haytor
    Main Street
    NN6 8BU East Haddon
    Northampton
    Administrateur
    Haytor
    Main Street
    NN6 8BU East Haddon
    Northampton
    United KingdomBritishCompany Director31870080001
    BARKER, Anthony
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    Secrétaire
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    BritishAccountant83350930002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Secrétaire
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    BritishCompany Director83350930001
    DAVID, Alastair Cameron
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Northumberland Road
    CV32 6HG Leamington Spa
    108
    Warwickshire
    United Kingdom
    British130261580001
    GATFORD, Kerry Louise
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    Secrétaire
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    BritishParalegal Assistant58359470002
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    BritishFinance Director69196950002
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    4 Red Cedar Road
    MK43 8GL Bromham
    Bedfordshire
    Administrateur
    4 Red Cedar Road
    MK43 8GL Bromham
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director256777440001
    BARKER, Anthony
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    Administrateur
    7 Mear Drive
    Borrowash
    DE72 3QW Derby
    BritishAccountant83350930002
    BARKER, Anthony
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    Administrateur
    11 Pollards Close
    Derbywash
    DE72 3QU Derbyshire
    BritishCompany Director83350930001
    BROWN, Julia Diane
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    Administrateur
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 7XW Derby
    BritishSolicitor62842870002
    GASKELL, Paul Gordon
    60 Copeland Drive
    Standish
    WN6 0XR Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    60 Copeland Drive
    Standish
    WN6 0XR Wigan
    Lancashire
    BritishDirector77954730005
    GATFORD, Kerry Louise
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    Administrateur
    18 Rectory Road
    West Bridgford
    NG2 6BG Nottingham
    BritishParalegal Assistant58359470002
    GORDON, Harry Stuart
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Greylands Mereside Road
    Mere
    WA16 6QQ Knutsford
    Cheshire
    BritishOperations Manager25073230002
    GRAY, Roger Charles
    3 Litton Close
    NG15 9EW Ravenshead
    Nottingham
    Administrateur
    3 Litton Close
    NG15 9EW Ravenshead
    Nottingham
    BritishCompany Director77954750001
    KING, Anthony Clive Garner
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    Administrateur
    Gowan Bank
    47 Broadway
    DE56 4BU Duffield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director108853950001
    LEWIS, Huw Roderic
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    Administrateur
    26 Chattaway Drive
    Balsall Common
    CV7 7QH Coventry
    Warwickshire
    BritishAccountant13419660001
    NEWSOME, Adrian John
    4 Wingate Drive
    MK45 2XF Ampthill
    Bedfordshire
    Administrateur
    4 Wingate Drive
    MK45 2XF Ampthill
    Bedfordshire
    BritishCompany Director85846970001
    PROSSER, Michael Trevelyan
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    73 Merlin Way
    Mickleover
    DE3 5UJ Derby
    Derbyshire
    BritishFinance Director69196950002
    ROBERTS, Paul Philip
    Diamond House
    Odell Road Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    Administrateur
    Diamond House
    Odell Road Sharnbrook
    MK44 1JL Bedford
    BritishCompany Director94196530001
    WALTER, Derek Edmund Piers
    Hazelewell Road
    Putney
    SW15 6GT London
    19
    Administrateur
    Hazelewell Road
    Putney
    SW15 6GT London
    19
    EnglandBritishCompany Director155090910001
    WHITE, Geoffrey Charles
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    Administrateur
    8 Rawlings Street
    SW3 2LS London
    BritishAccountant86433340001
    WHITTAKER, David
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    Administrateur
    106 Gray Run
    Huntsville
    Alabama 35824
    Usa
    BritishCompany Director82130600001
    WOODWARK, Christopher John Stuart
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    Administrateur
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    EnglandBritishCompany Director29679520001

    PRESSAC (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 03 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h land and buildings on the south east side of glaisdale drive west bilborough nottingham nottinghamshire t/n NT209316. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 03 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a land and buildingson the south east side of glasidale driv. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 04 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgaged chattels,the benefit of any guarantee,warranty or other obligation in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 04 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 23 févr. 2006
    Livré le 04 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Euro Sales Finance PLC
    Transactions
    • 04 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Security agreement
    Créé le 31 juil. 2002
    Livré le 07 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All estates or interests in any freehold or leasehold property with all buildings,fixtures,fittings,fixed plant and machinery thereon; the benefit of any covenants for title or any moneys paid thereunder; all shares in any member of the group and all stocks,debentures,bonds or other securities and investments,dividend,right,money or property accruing; all amounts standing to the credit of any account and all book/other debts,securities or guarantees; all other contracts and intellectual property; see form 395 for details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC,as Agent and Trustee for the Transaction Parties
    Transactions
    • 07 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0