FORESIGHT VCT PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFORESIGHT VCT PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03421340
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FORESIGHT VCT PLC ?

    • Gestion de fonds (66300) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe FORESIGHT VCT PLC ?

    Adresse du siège social
    C/O Foresight Group Llp The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FORESIGHT VCT PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORESIGHT TECHNOLOGY VCT PLC20 août 199720 août 1997
    BACKSIGHT TECHNOLOGY VCT PLC19 août 199719 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de FORESIGHT VCT PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FORESIGHT VCT PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au10 oct. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation24 oct. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au10 oct. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour FORESIGHT VCT PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 16 oct. 2025

    • Capital: GBP 3,009,667.37
    6 pagesSH07

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 janv. 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Nomination de Denise Josephine Hadgill en tant qu'administrateur le 01 nov. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 10 oct. 2025 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Annulation d'actions par une SA. État du capital au 30 juin 2025

    • Capital: GBP 3,039,140.83
    4 pagesSH07

    Rachat d'actions propres.

    6 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 août 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    État du capital après une attribution d'actions au 30 juin 2025

    • Capital: GBP 3,047,516.13
    3 pagesSH01

    Annulation d'actions. État du capital au 12 mai 2025

    • Capital: GBP 3,014,845.84
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    01 juil. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    124 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Re - director's authorisation, market purchases 02/06/2025
    RES13
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    État du capital après une attribution d'actions au 09 mai 2025

    • Capital: GBP 3,060,214.48
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 avr. 2025

    • Capital: GBP 3,015,778.86
    6 pagesSH01

    Annulation d'actions. État du capital au 20 déc. 2024

    • Capital: GBP 2,717,792.53
    4 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 avr. 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    État du capital après une attribution d'actions au 13 mars 2025

    • Capital: GBP 3,012,642.03
    6 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 14 févr. 2025

    • Capital: GBP 3,011,628.66
    5 pagesSH01

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 mars 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    État du capital après une attribution d'actions au 07 févr. 2025

    • Capital: GBP 3,003,647.92
    6 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 27 janv. 2025

    • Capital: GBP 2,852,245.07
    6 pagesSH01

    Annulation d'actions. État du capital au 28 juin 2024

    • Capital: GBP 2,754,787.83
    6 pagesSH06

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 déc. 2024Clarification HMRC confirmation received appropriate stamp duty has been paid on this transaction

    Annulation d'actions. État du capital au 18 oct. 2024

    • Capital: GBP 2,729,840.72
    6 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 27 oct. 2023

    • Capital: GBP 2,456,225.60
    4 pagesSH06

    Annulation d'actions. État du capital au 28 avr. 2024

    • Capital: GBP 2,754,787.83
    4 pagesSH06

    Qui sont les dirigeants de FORESIGHT VCT PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FORESIGHT GROUP LLP
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementOC300878
    157761490001
    DIMOND, Patricia
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    EnglandBritish284192340001
    FORD, David Ian
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    EnglandBritish231044550002
    HADGILL, Denise Josephine
    C/O Foresight Group Llp
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Th Shard
    United Kingdom
    Administrateur
    C/O Foresight Group Llp
    The Shard, 32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Th Shard
    United Kingdom
    United KingdomBritish342078520001
    LITTLEJOHNS, Margaret
    Priory Avenue
    W4 1TZ London
    43
    England
    Administrateur
    Priory Avenue
    W4 1TZ London
    43
    England
    EnglandBritish28696310002
    SANDHU, Dharminder Singh
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    C/O Foresight Group Llp
    United Kingdom
    EnglandBritish304243400002
    BLEARS, Roger William
    Oakwood The Green
    Rous Lench
    WR11 4UN Evesham
    Hereford And Worcester
    Secrétaire
    Oakwood The Green
    Rous Lench
    WR11 4UN Evesham
    Hereford And Worcester
    British27958240002
    LLP, Foresight Group
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    United Kingdom
    Secrétaire
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    United Kingdom
    239843340001
    FORESIGHT FUND MANAGERS LIMITED
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Secrétaire
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    The Shard
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03135882
    99414410003
    BLEARS, Roger William
    Oakwood The Green
    Rous Lench
    WR11 4UN Evesham
    Hereford And Worcester
    Administrateur
    Oakwood The Green
    Rous Lench
    WR11 4UN Evesham
    Hereford And Worcester
    United KingdomBritish27958240002
    DICKS, Peter Frederick
    40 Parkgate Road
    SW11 4NT London
    Flat 6, Parkgate House
    England
    Administrateur
    40 Parkgate Road
    SW11 4NT London
    Flat 6, Parkgate House
    England
    EnglandBritish54660290007
    DIMENT, Anthony Richard
    Mauna Loa
    Islet Park Drive
    SL6 8LF Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Mauna Loa
    Islet Park Drive
    SL6 8LF Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish3185670001
    ENGLISH, Peter David
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    Administrateur
    76 Woodside
    Wimbledon
    SW19 7QL London
    British3355360001
    FAIRMAN, Bernard William
    Blackthorne House
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Blackthorne House
    Springwood Park
    TN11 9LZ Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish9367430004
    GREGORY, John Howard
    Whitchurch Road
    Cublington
    LU7 0UP Nr Leighton Buzzard
    Fern House
    England
    Administrateur
    Whitchurch Road
    Cublington
    LU7 0UP Nr Leighton Buzzard
    Fern House
    England
    United KingdomBritish153555800002
    HARRIS, Jocelin Montague St John
    Pembroke Square
    W8 6PB London
    21
    England
    Administrateur
    Pembroke Square
    W8 6PB London
    21
    England
    United KingdomBritish3078360002
    HORNE, Nigel, Dr
    Whitefriars
    Hosey Hill
    TN16 1TA Westerham
    Kent
    Administrateur
    Whitefriars
    Hosey Hill
    TN16 1TA Westerham
    Kent
    British51059210001
    HUMPHRIES, Gordon James
    113 Caiyside
    EH10 7HR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    113 Caiyside
    EH10 7HR Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish106942950001
    LYTHALL, John
    29 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    29 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish15080690001
    ROYDS, David John George
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    Administrateur
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    EnglandBritish141447410001
    MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    Administrateur
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    40496750001
    PHILSEC LIMITED
    No 1 Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    No 1 Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    West Midlands
    100887680001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0