ROBINSON MANUFACTURING LIMITED

ROBINSON MANUFACTURING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROBINSON MANUFACTURING LIMITED
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03422571
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    TENEO FINANCIAL ADVISORY LIMITED
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 sept. 2022
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 août 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation03 sept. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 août 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Samantha Gartside en tant que directeur le 22 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Satisfaction de la charge 034225710007 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    18 pagesAM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    57 pagesAM06

    Changement d'adresse du siège social de Unit 25 Meadow Close Ise Valley Industrial Estate, Finedon Road Wellingborough Northamptonshire NN8 4BH à The Colmore Building, 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT le 15 mai 2023

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Matthew Roy Davies en tant que directeur le 24 avr. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2021

    28 pagesAA

    Nomination de Mr Matthew Jan Korny en tant qu'administrateur le 14 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew Roy Davies en tant qu'administrateur le 14 oct. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Samantha Gartside en tant qu'administrateur le 14 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2020

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2019

    29 pagesAA

    Satisfaction de la charge 034225710011 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    26 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Glyn Alec Hilson en tant que directeur le 10 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 20 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2018

    27 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KIDNEY, Simon David
    Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building, 20
    Administrateur
    Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building, 20
    EnglandBritishDirector179290930001
    KORNY, Matthew Jan
    Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building, 20
    Administrateur
    Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    The Colmore Building, 20
    EnglandBritishDirector288400460001
    SMY, Mark Robert
    Parcell Walk
    Godmanchester
    PE29 2YL Huntingdon
    11
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Parcell Walk
    Godmanchester
    PE29 2YL Huntingdon
    11
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDesigner134034080001
    ROBINSON, Elisabeth Anne
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    BritishCompany Director54298220003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVIES, Matthew Roy
    Unit 25 Meadow Close Ise Valley
    Industrial Estate, Finedon Road
    NN8 4BH Wellingborough
    Northamptonshire
    Administrateur
    Unit 25 Meadow Close Ise Valley
    Industrial Estate, Finedon Road
    NN8 4BH Wellingborough
    Northamptonshire
    EnglandBritishHealth And Safety Director288345580001
    GARTSIDE, Samantha
    Laurel Valley
    NN4 0YU Northampton
    7
    England
    Administrateur
    Laurel Valley
    NN4 0YU Northampton
    7
    England
    United KingdomBritishFinance Director116150160002
    HILSON, Glyn Alec
    London Road
    Raunds
    NN9 6EH Wellingborough
    77
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Administrateur
    London Road
    Raunds
    NN9 6EH Wellingborough
    77
    Northamptonshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishTimber Merchant134350140001
    KING, Nigel
    Riverside Drive
    Branston
    DE14 3EP Burton-On-Trent
    7
    Staffordshire
    England
    Administrateur
    Riverside Drive
    Branston
    DE14 3EP Burton-On-Trent
    7
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishAccountant134022840005
    MCMINN, John
    The Gallops Old Station Road
    CB8 8LA Newmarket
    8
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    The Gallops Old Station Road
    CB8 8LA Newmarket
    8
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishSales & Marketing134052760001
    ROBINSON, Elisabeth Anne
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director54298220003
    ROBINSON, Timothy William
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    Main Street
    Drayton
    LE16 8SD Market Harborough
    College Farm
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director2912520002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROBINSON MANUFACTURING LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Meadow Close, Ise Valley Industrial Estate
    NN8 4BH Wellingborough
    25
    Northamptonshire
    England
    06 avr. 2016
    Meadow Close, Ise Valley Industrial Estate
    NN8 4BH Wellingborough
    25
    Northamptonshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement09667241
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ROBINSON MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 mai 2018
    Livré le 03 mai 2018
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2015
    Livré le 03 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H land and buildings at the north side of vaux road 27-29 don white road wellingborough t/no.NN284170.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2015
    Livré le 03 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nigel King
    Transactions
    • 03 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2015
    Livré le 03 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Elisabeth Anne Robinson
    Transactions
    • 03 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 oct. 2015
    Livré le 03 oct. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Timothy William Robinson
    Transactions
    • 03 oct. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 juil. 2013
    Livré le 29 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Assignment. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 29 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 août 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 10 déc. 2010
    Livré le 11 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Floating charge
    Créé le 05 févr. 2010
    Livré le 09 févr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 09 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 29 déc. 2008
    Livré le 05 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The goods being lancer boss 546 used serial no 100500503 dec 2001 sideloader,lancer boss 546 used 100018698 apr 2001 sideloader,jungheinrich 546 used LA3618 mar 03 sideloader (for further details of goods charged please refer to form 395).
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 12 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 1.46 acres of land and buildings at ogee business park wellingborough northamptonshire.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 10 oct. 1997
    Livré le 11 oct. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Credit Services Limited
    Transactions
    • 11 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1997
    Livré le 01 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    ROBINSON MANUFACTURING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 mai 2023Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew James Cowlishaw
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    practitioner
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    Paul James Meadows
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham
    practitioner
    The Colmore Building, 20 Colmore Circus
    Queensway
    B4 6AT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0