WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED

WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03422853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE PLC31 mars 200031 mars 2000
    LOGICAL HOLDINGS LIMITED23 sept. 199723 sept. 1997
    51 VSQ LIMITED15 août 199715 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de C/O Temenos Uk Limited 71 Fenchurch Street London EC3M 4TD à One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH le 05 janv. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 déc. 2017

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 06 déc. 2017

    • Capital: GBP 387,990.024
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 06/12/2017
    RES13

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Temenos Group Ag en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Desmond James Noctor le 01 oct. 2016

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Nomination de Mr Olivier Pennese en tant qu'administrateur le 11 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David George Carruthers en tant que secrétaire le 15 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 sept. 2015

    État du capital au 29 sept. 2015

    • Capital: GBP 387,990.024
    SH01

    Nomination de Mr Mark Nicholas Gunning en tant qu'administrateur le 31 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Constantine Pangalos Christodoulou en tant que directeur le 31 janv. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2014

    État du capital au 18 sept. 2014

    • Capital: GBP 387,990.024
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2013

    État du capital au 28 oct. 2013

    • Capital: GBP 387,990.024
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUNNING, Mark Nicholas
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    EnglandBritish194656820001
    NOCTOR, Desmond James
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    Administrateur
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    EnglandIrish173598340002
    PENNESE, Olivier
    c/o Temenos Uk Ltd
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    71
    England
    Administrateur
    c/o Temenos Uk Ltd
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    71
    England
    United KingdomFrench207070730001
    CARRUTHERS, David George
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    C/O Temenos Uk Limited 71
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    C/O Temenos Uk Limited 71
    British151581220001
    DAVIDSON, Ian Todd
    16 Oldborough Drive
    Loxley
    CV35 9HQ Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Oldborough Drive
    Loxley
    CV35 9HQ Warwick
    Warwickshire
    British70125640002
    HUGHES, Jonathan
    12 Woodchester
    West Hagley
    DY9 0NF Stourbridge
    West Midlands
    Secrétaire
    12 Woodchester
    West Hagley
    DY9 0NF Stourbridge
    West Midlands
    British54810780001
    HUGHES, Jonathon Philip
    20 Long Compton Drive
    DY9 0PD Hagley
    Worcestershire
    Secrétaire
    20 Long Compton Drive
    DY9 0PD Hagley
    Worcestershire
    British85132180001
    KLANGA, Andre
    Riverway
    N13 5LJ London
    46
    Secrétaire
    Riverway
    N13 5LJ London
    46
    British133510490001
    NANDRA, Harvinder Singh
    3 Church Hill Road
    Handsworth
    B20 3TN Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Church Hill Road
    Handsworth
    B20 3TN Birmingham
    West Midlands
    British108914780001
    OWEN, Gary John
    3 Beechwood Croft
    Little Aston
    B74 3UU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    3 Beechwood Croft
    Little Aston
    B74 3UU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54718650002
    TRIGG, Giles Roderick Leslie
    Birch Cottage
    Brake Lane
    DY8 2XW Hagley
    Worcestershire
    Secrétaire
    Birch Cottage
    Brake Lane
    DY8 2XW Hagley
    Worcestershire
    British110383510001
    VICTORIA SQUARE SECRETARIES LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748190001
    BAILEY, Bryan
    Woodfield
    KT21 2RL Ashtead
    Rye Brook
    Surrey
    Administrateur
    Woodfield
    KT21 2RL Ashtead
    Rye Brook
    Surrey
    United KingdomBritish132568740001
    CARRUTHERS, David George
    2 The Orchard On The Green
    WD3 3HS Croxley Green
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 The Orchard On The Green
    WD3 3HS Croxley Green
    Hertfordshire
    EnglandBritish107591870001
    CHRISTODOULOU, Constantine Pangalos
    c/o Temenos Uk Limited
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    71
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Temenos Uk Limited
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    71
    United Kingdom
    United KingdomoBritish151497820001
    DAVIDSON, Ian Todd
    16 Oldborough Drive
    Loxley
    CV35 9HQ Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    16 Oldborough Drive
    Loxley
    CV35 9HQ Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish70125640002
    FOLL, Paul Jonathan
    18
    Ray Park Avenue
    SL6 8DS Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    18
    Ray Park Avenue
    SL6 8DS Maidenhead
    Berkshire
    British2551750002
    FOSTER, Roger Keith
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    Administrateur
    Seisdon Hall
    Seisdon
    WV5 7ER South Staffordshire
    EnglandBritish2551760001
    FRUMKIN, Simon
    4 Crediton Hill
    NW6 1HP London
    Administrateur
    4 Crediton Hill
    NW6 1HP London
    British102459210001
    LOACH, Paul
    17 Stanhope Road
    N6 5AW London
    Administrateur
    17 Stanhope Road
    N6 5AW London
    British80576980001
    NEWTON, Richard Paul
    27 Waterside Court
    Saint Vincent Street
    B16 8EY Birmingham
    Administrateur
    27 Waterside Court
    Saint Vincent Street
    B16 8EY Birmingham
    British50919720002
    OWEN, Gary John
    3 Beechwood Croft
    Little Aston
    B74 3UU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Beechwood Croft
    Little Aston
    B74 3UU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British54718650002
    PAPPA, Athena Sofia
    66 Chiswick Green Studios
    1 Evershed Walk
    W4 5BW London
    Administrateur
    66 Chiswick Green Studios
    1 Evershed Walk
    W4 5BW London
    United KingdomGreek111595480001
    PEER, Karim
    Pilgrims Way
    GU35 8LB Headley
    2
    Hampshire
    Administrateur
    Pilgrims Way
    GU35 8LB Headley
    2
    Hampshire
    United KingdomBritish93685630003
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Administrateur
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Canadian3035310003
    STONELL, Keith Robert
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    Administrateur
    Tars Platt
    Cookham Dean Common
    SL6 9PY Cookham Dean
    Berkshire
    EnglandBritish151579610001
    WHALE, Michael Edward
    7 The Mews
    Berkswell Hall
    CV7 7BG Berkswell
    Warwickshire
    Administrateur
    7 The Mews
    Berkswell Hall
    CV7 7BG Berkswell
    Warwickshire
    British44844670002
    VICTORIA SQUARE DIRECTORS LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748210001
    VICTORIA SQUARE SECRETARIES LIMITED
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    1 Victoria Square
    B1 1BD Birmingham
    West Midlands
    44748190001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Financial Objects Limited
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    C/O Temenos Uk Limited, 71 Fenchurch Street, Londo
    England
    06 avr. 2016
    Fenchurch Street
    EC3M 4TD London
    C/O Temenos Uk Limited, 71 Fenchurch Street, Londo
    England
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementSwitzerland
    Autorité légaleSwiss Law
    Lieu d'enregistrementFederal Commercial Registry Office
    Numéro d'enregistrementCh0012453913
    Rechercher dans le registre du commerce suisse (Zefix)Financial Objects Limited
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 mars 2005
    Livré le 02 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 10 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 22 oct. 2004
    Livré le 02 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 1998
    Livré le 06 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I Group PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 sept. 1997
    Livré le 18 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or 52 vsq limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 déc. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WEALTH MANAGEMENT SOFTWARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2019Dissolved on
    07 déc. 2017Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    One Snowhill Snowhill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0