WAVENEY SHIPPING PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWAVENEY SHIPPING PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 03424691
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WAVENEY SHIPPING PLC ?

    • (6110) /

    Où se situe WAVENEY SHIPPING PLC ?

    Adresse du siège social
    C/O Begbies Traynor (South) Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WAVENEY SHIPPING PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2005

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour WAVENEY SHIPPING PLC ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour WAVENEY SHIPPING PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 avr. 2014

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2012

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2013

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 juil. 2010

    5 pages4.68

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de WAVENEY SHIPPING PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROSTRON, Peter James
    St Peters House
    Cattle Market Street
    NR1 3DY Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    St Peters House
    Cattle Market Street
    NR1 3DY Norwich
    Norfolk
    British10092480002
    COBB, David Bilsland
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    British73830490002
    ROYDS, David John George
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    Administrateur
    Lyford Road
    SW18 3LU London
    21
    EnglandBritish141447410001
    HARRIS, Michael Lionel
    5 Briar Road
    HA3 0DP Kenton
    Middlesex
    Secrétaire
    5 Briar Road
    HA3 0DP Kenton
    Middlesex
    British18692980001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    DOUGLAS, John Campbell
    Kingswear House
    Church Hill, Kingswear
    TQ6 0BX Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    Kingswear House
    Church Hill, Kingswear
    TQ6 0BX Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritish1822320003
    LISTER, Charles Lees
    Haggle House
    Scole Road, Thorpe Abbotts
    IP21 4HS Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Haggle House
    Scole Road, Thorpe Abbotts
    IP21 4HS Diss
    Norfolk
    British36741080009
    ROSTRON, Peter James
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    373 Unthank Road
    NR4 7QG Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish10092480004
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur
    120 East Road
    N1 6AA London
    38524190001

    WAVENEY SHIPPING PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of assignment
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 01 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate principal amount not exceeding £18,750,000 and all other monies due or to become due from any of the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the assigned property k/a the insurances, earnings, the charter rights and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alliance & Leicester Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A first priority british ship mortgage
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 01 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64 shares in the vessel, length 72.00 metres, breadth 16.00 metres, depth 7.00 metres, tons gross 2161.00 and tons net 1073.00 and any interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alliance and Leicester Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of covenants
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 01 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate principal amount not exceeding £18,750,000 and all other monies due or to become due from any of the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64TH shares in a vessel, length 72.00 metres, breadth 16.00 metres, depth 7.00 metres, tons gross 2161.00 and tons net 1073.00 and any interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Alliance & Leicester Commercial Bank PLC
    Transactions
    • 01 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 11 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned property meaning the insurances the earnings the charter rights and the requisition compensation. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of covenants
    Créé le 11 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64TH/64TH shares in the vessel, a motor vessel of the following dimensions and tonnages length overall: 66.30 metres, breadth: 16.00 metres, depth: 7.00 metres, tons gross: 2161.00, tons net: 1073.00 and includes any interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    First priority british ship mortgage
    Créé le 11 avr. 2003
    Livré le 24 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64TH/64TH shares in the vessel, a motor vessel of the following dimensions and tonnages length overall: 66.30 metres, breadth: 16.00 metres, depth: 7.00 metres, tons gross: 2161.00, tons net: 1073.00 and includes any interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Account security deed
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 16 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £18,750,000 due or to become due from the company and waveney shipping ii PLC to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The account balances and all other rights titles and interests of the borrowers in and to the accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 10 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of shipbuilding contract and refund guarantee
    Créé le 30 sept. 2002
    Livré le 10 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys, liabilities and obligations due or to become due from waveney shipping PLC ("waveney I") and waveney shipping ii PLC ("waveney ii") (the "borrowers") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest in and to all benefits under or pursuant to the building contract and the refund guarantee and all sums payable thereon and all the buyer's rights in and to the vessel with hull no 98. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 28 avr. 2000
    Livré le 15 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 28TH november 1997 and/or any of the other agreements as defined
    Brèves mentions
    And any patent,copyright,design,trade mark,invention,drawing,etc; the benefit of any licence. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account charge
    Créé le 28 avr. 2000
    Livré le 15 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 28TH november 1997 and/or any of the other agreements as defined
    Brèves mentions
    All right,title and interest whatsoever in all amounts from time to time and credited to the credit of various account numbers as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second statutory mortgage
    Créé le 02 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 28TH november 1997 and a deed of covenants dated 2ND june 1999
    Brèves mentions
    64/64TH shares of the M.V. waveney castle official no.901884 And its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second deed of covenants
    Créé le 02 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 28TH november 1997 and the security documents (as defined in the deed of covenants)
    Brèves mentions
    M.V. waveney castle official no. 901884 including any share or interest therein and all freight hire and any other amounts earned or payable for the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second account charge
    Créé le 02 juin 1999
    Livré le 15 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 28TH november 1997, the security documents and the second security documents (as defined in the supplemental agreement)
    Brèves mentions
    All amounts from time to time credited to or standing to the credit of the account number 0745311 into which the earnings are to be paid. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenants
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 26 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 28TH november 1997 pursuant to which the bank has agreed to make available to the company, inter alia, a loan of up to £6,750,000 and the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    M.V. waveney castle official no. 901884 including any share or interest therein and all freight hire and any other amounts earned or payable for the account of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Account charge
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 26 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The aggregate of all amounts due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement dated 28TH november 1997 pursuant to which the bank has agreed to make available to the company, inter alia, a loan of up to £6,750,000 and the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    All amounts from time to time credited to or standing to the credit of the account number 0745311 into which the earnings are to be paid. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First statutory mortgage
    Créé le 19 mars 1999
    Livré le 26 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 28TH november 1997 and a deed of covenants dated 19TH march 1999
    Brèves mentions
    64/64TH shares of the M.V. waveney castle official no.901884 And its appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment agreement
    Créé le 28 nov. 1997
    Livré le 02 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined)
    Brèves mentions
    The company's right, title and interest in and under a shipbuilding contract dated 28TH august 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WAVENEY SHIPPING PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 janv. 2008Commencement of winding up
    17 juil. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Paul Hudson
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Vivian Murray Bairstow
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    practitioner
    Begbies Traynor
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0