BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

BTL REALISATIONS 2009 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBTL REALISATIONS 2009 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03425946
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    • (5190) /

    Où se situe BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERTRAM TRADING LIMITED05 juil. 200505 juil. 2005
    CYPHER HOLDINGS LIMITED05 mai 200005 mai 2000
    CYPHER GROUP LIMITED21 août 199721 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au02 févr. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 11 mars 2011

    21 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 11 mars 2011

    11 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 sept. 2010

    10 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 mars 2010

    12 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 sept. 2009

    12 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    47 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    46 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed bertram trading LIMITED\certificate issued on 23/03/09
    2 pagesCERTNM

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Comptes complets modifiés jusqu'au 02 févr. 2008

    25 pagesAAMD

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 02 févr. 2008

    25 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07
    capital

    Résolutions

    Authority to execute documents 29/08/2008
    RES13

    legacy

    8 pages155(6)a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    5 pages395

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de BTL REALISATIONS 2009 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LEEMING, Christopher
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    52 Mile End Road
    NR4 7QX Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish83952290001
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Secrétaire
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    British75314100001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Secrétaire
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    MCGONIGLE, Richard John
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    Secrétaire
    Greensleeves
    Bramley Corner
    RG26 5DJ Bramley
    British125002440001
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Secrétaire
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    ROBINSON, Michael John
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Lavenders 4 Drakes Loke
    Buxton
    NR10 5HU Norwich
    Norfolk
    British60420200003
    VERSEC SECRETARIES LIMITED
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    39 Alma Road
    AL1 3AT St. Albans
    Hertfordshire
    79043790001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BARNETSON, Graham
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    Administrateur
    Lawn Cottages
    51 Horton Road
    SL3 9LD Datchet
    Berkshire
    United KingdomBritish94018550003
    BROWN, Thomas Henry Phelps
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    Administrateur
    Tibthorpe Grange
    Tibthorpe
    YO25 9LG Driffield
    East Yorkshire
    United KingdomBritish4055550001
    ENGLISH, Paul Robert Forster
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    4 The Leys
    OX7 5HH Chipping Norton
    Oxfordshire
    British48135660002
    GRAHAM, David John
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    Administrateur
    Elm Green House
    Main Road
    CM3 4DL Danbury
    United KingdomBritish75314100001
    GRAY, Raymond John
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    Administrateur
    11 Bracken Park
    Scarcroft
    LS14 3HZ Leeds
    Yorkshire
    British58316960001
    HENDRIE, Ian Arthur
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    Administrateur
    Orchard Cottage
    Bunwell Street
    NR16 1NA Norwich
    United KingdomBritish123762920001
    HORRY, David
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    Administrateur
    Byways
    The Bent, Curbur
    S32 3YD Hope Valley
    United KingdomBritish95866490004
    HOWARD, Josephine Mary
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    2 Blenheim Terrace
    OX7 5HF Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritish94643210001
    IVEL, Nicholas
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    Administrateur
    5 Toll Bar Way
    York Road
    LS24 8JT Tadcaster
    North Yorkshire
    British1036930003
    LEWIS, Stephen Bernard
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    Administrateur
    11 London Road
    Loughton Village
    MK5 8AB Milton Keynes
    United KingdomBritish78249540002
    MILLS, Jeremy David Nash
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    Administrateur
    7 Abbey Fields
    IP14 3TA Haughley
    Suffolk
    British92977300001
    NEIL, Michael Hugh
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    Administrateur
    Bourton On The Hill
    GL56 9AH Gloucester
    The Bank House
    United KingdomBritish129915950001
    NICHOLLS, Julian Frederick
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Thatched Cottage
    Smiths End Lane Barley
    SG8 8LH Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish95086050001
    REILLY, Terence Michael
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hillside
    Barrack Hill
    HP7 0LW Coleshill
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88886600001
    ROBINSON, Michael John
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Holly Tree House
    Skipwith Road Escrick
    YO19 6JT York
    North Yorkshire
    EnglandBritish115823780001
    WIGGLESWORTH, Lloyd John
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    Administrateur
    Latton
    Cricklade
    SN6 6DP Swindon
    Latton House
    England
    EnglandBritish128029980001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    BTL REALISATIONS 2009 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 mai 2008
    Livré le 03 juin 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Book debts debenture
    Créé le 27 mars 2007
    Livré le 04 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all purchased debts together with their related rights,and by way of floating charge the other debts together with their related rights and such moneys which the company may receive in respect of the other debts.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 2005
    Livré le 18 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The land and buildings at enfield road, morley, leeds. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 18 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 16 août 2001
    Livré le 30 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any member of the group (as defined) to the chargee as security trusteee for the security beneficiaries (as defined) (the "security trustee") whether pursuant to the a loan note instrument, the b loan note instrument, the a notes, the b notes, the guarantee (all as defined) or otherwise on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited
    Transactions
    • 30 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 17 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries) whether pursuant to the loan note instrument, the notes, guarantee or otherwise
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited
    Transactions
    • 17 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 12 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited
    Transactions
    • 12 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 10 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The policies and all monies including bonuses accrued or which may at any time accrue which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 févr. 1999
    Livré le 10 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 10 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 févr. 1998
    Livré le 19 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all debts (purchased or to be purchased by the security holder pursuant to the agreement) which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (as defined) pertaining to such debts and floating charge all undertaking property rights and assets of the company present and future present and future stock in trade uncalled capital not charged by way of fixed charge above.
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 sept. 1997
    Livré le 26 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a subscription agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Development Capital Limited (As Security Trustee for Itself and the Investors)
    Transactions
    • 26 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 sept. 1997
    Livré le 19 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 19 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BTL REALISATIONS 2009 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    11 mars 2011Administration ended
    20 mars 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian Best
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    One Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0