SCISYS UK HOLDING LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCISYS UK HOLDING LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03426416
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCISYS UK HOLDING LTD ?

    • Développement de logiciels professionnels et grand public (62012) / Information et communication
    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication
    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Adresse du siège social
    20 Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SCISYS UK HOLDING PLC20 déc. 201820 déc. 2018
    SCISYS PLC26 sept. 200626 sept. 2006
    CODASCISYS PLC.28 juin 200228 juin 2002
    SCIENCE SYSTEMS PLC29 août 199729 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Statuts

    10 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The directors of the company be authorised to capitalise the £942,670.24 amount standing to the credit of the merger reserve by way of bonus issue and that the directors of the company be and are hereby authorised to apply such sum in paying up in full 3,770,680 ordinary shares of £0.25 each in the capital of the company and the directors of the company are hereby directed to allot and issue such shares, credited as fully paid up. To cgi it ireland LIMITED, the sole shareholder of the company. 19/12/2022
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 22 déc. 2023

    • Capital: GBP 8,338,835.00
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account the company and is hereby cancelled 19/12/2023
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 19 déc. 2023

    • Capital: GBP 8,338,835
    3 pagesSH01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2022 au 30 juin 2023

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 23 sept. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    24 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 23 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darryl Eades le 10 août 2022

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    24 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 23 sept. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Modification des détails de Scisys Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mars 2020

    2 pagesPSC05

    Qui sont les dirigeants de SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LANDRY MALTAIS, Sarah
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    265528330001
    BOULANGER, François
    Réné-Lévesque Blvd. W.
    25th Floor
    H3G1T4 Montreal
    1350
    Quebec
    Canada
    Administrateur
    Réné-Lévesque Blvd. W.
    25th Floor
    H3G1T4 Montreal
    1350
    Quebec
    Canada
    CanadaCanadian265463690001
    EADES, Darryl
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish276139200002
    MCGEEHAN, Tara, Ms.
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    United KingdomBritish242289410001
    BELMONT, David Gresford
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    4 Glenview Close
    Nab Wood
    BD18 4AZ Shipley
    West Yorkshire
    British99897870001
    HUCKER, Bryan Herbert
    Crestfield House
    Tetbury Road Sherston
    SN16 0LU Malmesbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Crestfield House
    Tetbury Road Sherston
    SN16 0LU Malmesbury
    Wiltshire
    British7560560003
    LAIRD, Natasha Louise
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Secrétaire
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    216315540001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Secrétaire
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    British101309030001
    MURDEN, Martin Peter
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Secrétaire
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    British89690050001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Secrétaire désigné
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001160001
    BEST, David Graham
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Toftwood
    East Common
    AL5 1DD Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish34249020002
    BRIGNALL, Stephen
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    United KingdomBritish116089640001
    CHEETHAM, Christopher Andrew
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    EnglandBritish78076620007
    COGHLAN, David John
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    No 2
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Methuen Park
    SN14 0GB Chippenham
    No 2
    Wiltshire
    United Kingdom
    EnglandBritish,Australian35532810001
    GREIG, Michael David
    Yew Tree Barn The Paddocks
    Main Street
    OX12 0HX East Hanney
    Oxfordshire
    Administrateur
    Yew Tree Barn The Paddocks
    Main Street
    OX12 0HX East Hanney
    Oxfordshire
    British24411590005
    HAMPSON, Simon Mark
    Scala Cottage
    The Old Rectory, Luckington
    SN14 6PH Chippenham
    Wiltshire
    Administrateur
    Scala Cottage
    The Old Rectory, Luckington
    SN14 6PH Chippenham
    Wiltshire
    British87042590002
    HAYNES, John Balfour, Dr
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    Administrateur
    Steep Oakridge Lane
    Winscombe
    BS25 1LZ Somerset
    Avon
    EnglandBritish200888890001
    HEIDRICH, Klaus Martin
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    GermanyGerman165695430001
    HUCKER, Bryan Herbert
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    Administrateur
    Northlew
    Lansdowne Road
    BA1 5TD Bath
    Bnes
    EnglandBritish7560560005
    JONES, David Rodney
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    WalesBritish69172140002
    LOVE, Michael David, Dr
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    United KingdomEnglish7560570001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Administrateur
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    United KingdomBritish101309030001
    MENG, Klaus Gunter, Dr
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    Administrateur
    Methuen Park
    Chippenham
    SN14 0GB Wiltshire
    GermanyGerman135719390002
    METCALFE, George Ralph Anthony
    4 Tower Street
    GL7 1EF Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    4 Tower Street
    GL7 1EF Cirencester
    Gloucestershire
    British1719720001
    MOHAMMED, Faris Mehdi Kadhim
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Fenchurch Street
    14th Floor
    EC3M 3BY London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish67645590001
    PREDDY, Clifford Stanley Frank
    18 Croham Park Avenue
    CR2 7HH South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    18 Croham Park Avenue
    CR2 7HH South Croydon
    Surrey
    British11201910001
    REIMERS, Ulrich, Dr
    Kollwitzstrasse 38
    Vechelde
    38159
    Germany
    Administrateur
    Kollwitzstrasse 38
    Vechelde
    38159
    Germany
    German135719560001
    ROCHE, Jeremy Byron
    Old School House
    OX13 5EP Longworth
    Oxfordshire
    Administrateur
    Old School House
    OX13 5EP Longworth
    Oxfordshire
    British39969820002
    STEINSBERG, Graham Lawrence
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Bakers Close
    104 Lower Radley
    OX14 3BA Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish34515710002
    WELLS, Mark Benjamin
    Fir Tree Avenue
    Stoke Poges
    SL2 4NN Slough
    Vanbrugh House
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Fir Tree Avenue
    Stoke Poges
    SL2 4NN Slough
    Vanbrugh House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish140548510001
    NQH (CO SEC) LIMITED
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    Administrateur
    Third Floor Narrow Quay House
    Prince Street
    BS1 4AH Bristol
    Avon
    75423270001
    NQH LIMITED
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    Administrateur désigné
    Narrow Quay House
    Narrow Quay
    BS1 4AH Bristol
    900001150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Scisys Group Limited
    Barrow Street
    4 Dublin
    6th Floor South Bank House
    Ireland
    27 nov. 2018
    Barrow Street
    4 Dublin
    6th Floor South Bank House
    Ireland
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementIreland
    Autorité légaleIrish Law
    Lieu d'enregistrementCompanies Registration Office (Cro)
    Numéro d'enregistrement633147
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SCISYS UK HOLDING LTD ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    31 juil. 201727 nov. 2018La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SCISYS UK HOLDING LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 29 nov. 2016
    Livré le 01 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold premises known as 2 methuen park, chippenham, SN14 0GB registered with title number WT161177.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lesmoir-Gordon, Boyle & Co. Limited
    Transactions
    • 01 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 févr. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 26 mai 2011
    Livré le 01 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a methuen park chippenham wiltshire t/no. WT161177.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 2024Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 sept. 1998
    Livré le 12 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0