FIC MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | FIC MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03426499 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe FIC MANAGEMENT LIMITED ?
| Adresse du siège social | Hoplands Estate King's Somborne SO20 6QH Stockbridge Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de FIC MANAGEMENT LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2008 |
Quels sont les derniers dépôts pour FIC MANAGEMENT LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Nomination de Mr Kenneth John Stratton en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Kenneth Stratton en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008 | 3 pages | AA | ||
legacy | 3 pages | 363a | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007 | 3 pages | AA | ||
legacy | 3 pages | 363a | ||
legacy | 1 pages | 287 | ||
legacy | 1 pages | 190 | ||
legacy | 1 pages | 353 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2006 | 3 pages | AA | ||
legacy | 3 pages | 288a | ||
legacy | 7 pages | 363s | ||
legacy | 2 pages | 288a | ||
legacy | 1 pages | 288b | ||
legacy | 7 pages | 363s | ||
legacy | 7 pages | 363s | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2005 | 3 pages | AA | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Certificat de changement de nom Company name changed frobisher (romsey) LIMITED\certificate issued on 13/06/05 | 2 pages | CERTNM | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2003 | 3 pages | AA | ||
legacy | 7 pages | 363s | ||
Qui sont les dirigeants de FIC MANAGEMENT LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGHES, William Michael | Secrétaire | 44 Ashbarn Crescent SO22 4QJ Winchester Hampshire | British | 35470840001 | ||||||
| STRATTON, Kenneth John | Secrétaire | Court Road Kings Worthy SO23 7QA Winchester Kings Worthy House Hampshire | 148953230001 | |||||||
| WOLSTENHOLME, Nigel Timothy | Administrateur | Hoplands Estate Kings Somborne SO20 6QH Stockbridge Hampshire | United Kingdom | British | 45993000001 | |||||
| CLEDWYN, David Alun | Secrétaire | Byrony The Common Shedfield SO3 2JE Southampton Hampshire | British | 21866760003 | ||||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | 31 Corsham Street N1 6DR London | 78721330003 | |||||||
| CLEDWYN, David Alun | Administrateur | Byrony The Common Shedfield SO3 2JE Southampton Hampshire | England | British | 21866760003 | |||||
| STRATTON, Kenneth John | Administrateur | 3 Barley Down Drive SO22 4LS Winchester Hampshire | England | British | 65406620001 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Administrateur | 31 Corsham Street N1 6DR London | 78721330003 |
FIC MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal assignment of contracts | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 11 août 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined) | |
Brèves mentions All the company's rights title interest and benefit in to or arising under the contracts and all book debts and other debts revenues and claims both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 11 août 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a land at budds lane romsey. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 11 août 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 30 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements both dated 21ST july 1998 (as defined) | |
Brèves mentions Freehold land and buildings being units 2 and 5 frobisher industrial estate budds lane romsey in hampshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 24 juil. 1998 Livré le 29 juil. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of clause 4.5 and the provisions of the schedule to an agreement made 24TH april 1998 (as defined) | |
Brèves mentions Land at budds lane,romsey,hampshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge by agreement | Créé le 21 juil. 1998 Livré le 06 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The performance of the obligations of the company to the chargee owed under an agreement of even date made between the company, nigel timothy wolstenholme the chargee and raymond john stewart palmer | |
Brèves mentions Property k/a unit 2 frobisher industrial estate budds lane romsey hampshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge by agreement | Créé le 21 juil. 1998 Livré le 06 août 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti The performance of the obligations of the company to the chargee owed under an agreement of even date made between the company, nigel timothy wolstenholme the chargee and raymond john stewart palmer | |
Brèves mentions Property k/a unit 5 frobisher industrial estate budds lane romsey hampshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0