FIC MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIC MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03426499
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    • (7011) /
    • (7012) /
    • (7020) /

    Où se situe FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Hoplands Estate
    King's Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FROBISHER (ROMSEY) LIMITED29 août 199729 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Kenneth John Stratton en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Kenneth Stratton en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2008

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    3 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    7 pages363s

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2005

    3 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Certificat de changement de nom

    Company name changed frobisher (romsey) LIMITED\certificate issued on 13/06/05
    2 pagesCERTNM

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2003

    3 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de FIC MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HUGHES, William Michael
    44 Ashbarn Crescent
    SO22 4QJ Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    44 Ashbarn Crescent
    SO22 4QJ Winchester
    Hampshire
    British35470840001
    STRATTON, Kenneth John
    Court Road
    Kings Worthy
    SO23 7QA Winchester
    Kings Worthy House
    Hampshire
    Secrétaire
    Court Road
    Kings Worthy
    SO23 7QA Winchester
    Kings Worthy House
    Hampshire
    148953230001
    WOLSTENHOLME, Nigel Timothy
    Hoplands Estate
    Kings Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Hoplands Estate
    Kings Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish45993000001
    CLEDWYN, David Alun
    Byrony
    The Common Shedfield
    SO3 2JE Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Byrony
    The Common Shedfield
    SO3 2JE Southampton
    Hampshire
    British21866760003
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Secrétaire
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    78721330003
    CLEDWYN, David Alun
    Byrony
    The Common Shedfield
    SO3 2JE Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Byrony
    The Common Shedfield
    SO3 2JE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish21866760003
    STRATTON, Kenneth John
    3 Barley Down Drive
    SO22 4LS Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    3 Barley Down Drive
    SO22 4LS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish65406620001
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Administrateur
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    78721330003

    FIC MANAGEMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal assignment of contracts
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    All the company's rights title interest and benefit in to or arising under the contracts and all book debts and other debts revenues and claims both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land at budds lane romsey.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 11 août 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 11 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 30 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two agreements both dated 21ST july 1998 (as defined)
    Brèves mentions
    Freehold land and buildings being units 2 and 5 frobisher industrial estate budds lane romsey in hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Palmer Credit Partners Limited
    Transactions
    • 30 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 1998
    Livré le 29 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of clause 4.5 and the provisions of the schedule to an agreement made 24TH april 1998 (as defined)
    Brèves mentions
    Land at budds lane,romsey,hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Botany Investments Limited
    Transactions
    • 29 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge by agreement
    Créé le 21 juil. 1998
    Livré le 06 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance of the obligations of the company to the chargee owed under an agreement of even date made between the company, nigel timothy wolstenholme the chargee and raymond john stewart palmer
    Brèves mentions
    Property k/a unit 2 frobisher industrial estate budds lane romsey hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Palmer Capital Partners Limited
    Transactions
    • 06 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge by agreement
    Créé le 21 juil. 1998
    Livré le 06 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance of the obligations of the company to the chargee owed under an agreement of even date made between the company, nigel timothy wolstenholme the chargee and raymond john stewart palmer
    Brèves mentions
    Property k/a unit 5 frobisher industrial estate budds lane romsey hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Palmer Capital Partners Limited
    Transactions
    • 06 août 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0