COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD

COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03426633
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    • Activités des organisations professionnelles (94120) / Autres activités de services

    Où se situe COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Adresse du siège social
    Rossington's Business Park
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    COBRA CAPITAL RELEASE LIMITED19 févr. 200819 févr. 2008
    BKG MORTGAGES LIMITED27 juil. 200227 juil. 2002
    BKG PROPERTIES LIMITED22 nov. 200122 nov. 2001
    BURROWS KEITH PROPERTIES LIMITED29 août 199729 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven Redgwell le 13 janv. 2022

    2 pagesCH01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Carl Lloyd Mcmillan en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Gavin Matthew Perkins en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Steven Redgwell en tant qu'administrateur le 13 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Brendan James Mcmanus en tant que directeur le 13 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ryan Christopher Brown en tant que directeur le 13 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2020

    11 pagesAA

    legacy

    96 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael Bowler en tant que directeur le 09 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2019

    8 pagesAA

    legacy

    88 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    Modification des détails de Cobra Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2020 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des détails de Cobra Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 août 2020

    2 pagesPSC05

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2020 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David George Edward Stanley en tant que directeur le 01 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCMILLAN, Carl Lloyd
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish291243280001
    PERKINS, Gavin Matthew
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish291367680001
    REDGWELL, Steven
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish226334320002
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    Secrétaire
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    British13539620002
    DIXON, Janet Bryan
    Las Mercedes 32 Twinoaks
    KT11 2QP Cobham
    Surrey
    Secrétaire
    Las Mercedes 32 Twinoaks
    KT11 2QP Cobham
    Surrey
    British30326330001
    SLC REGISTRARS LIMITED
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    Secrétaire
    Thames House
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Surrey
    34893920004
    WILLOW TAXATION & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    1st Floor Curzon House
    24 High Street
    SM7 2LJ Banstead
    Surrey
    111052920001
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    England
    Administrateur
    Morley Road
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    England
    EnglandBritish13539620002
    BOWLER, Michael
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    Administrateur
    Morley Road
    Sanderstead
    CR2 0EN South Croydon
    28
    Surrey
    EnglandBritish13539620002
    BRIGHT, Peter John
    Buckingham Way
    SM6 9LU Wallington
    55
    Surrey
    Administrateur
    Buckingham Way
    SM6 9LU Wallington
    55
    Surrey
    EnglandBritish110864550001
    BROWN, Ryan Christopher
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    Administrateur
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish287066760001
    BURROWS, Stephen Mark
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    Administrateur
    Firdale
    East Parkside Great Park
    CR6 9PZ Warlingham
    Surrey
    United KingdomBritish13539590001
    KEITH, Colin Reginald
    Heath Cottage Colley Lane
    RH2 9DD Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Heath Cottage Colley Lane
    RH2 9DD Reigate
    Surrey
    British13539600001
    MCMANUS, Brendan James
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    Administrateur
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish128122260001
    POULTON, Hannah
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    Administrateur
    6 Daines Way
    SS1 3PF Southend On Sea
    Essex
    British99706350001
    SAUNDERS, Stephen David
    103 Oval Road
    CR0 6BR Croydon
    Surrey
    Administrateur
    103 Oval Road
    CR0 6BR Croydon
    Surrey
    EnglandBritish83911420001
    STANLEY, David George Edward
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    Administrateur
    12 Court Meadow Close
    TN6 3LW Rotherfield
    East Sussex
    EnglandBritish79784840001
    VERRELL, Rose Elizabeth
    46 Arundel Avenue
    CR2 8BB South Croydon
    Surrey
    Administrateur
    46 Arundel Avenue
    CR2 8BB South Croydon
    Surrey
    British47301700001
    WALLIS, Lee Grant
    10 Chaucer Close
    SM7 1PP Banstead
    Surrey
    Administrateur
    10 Chaucer Close
    SM7 1PP Banstead
    Surrey
    EnglandBritish27309640002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    West Carr Road
    DN22 7SW Retford
    Rossington's Business Park
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05548507
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    COBRA CORPORATE SOLUTIONS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 mars 2015
    Livré le 26 mars 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 06 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 sept. 2012
    Livré le 22 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Macquarie Bank Limited
    Transactions
    • 22 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 févr. 2009
    Livré le 26 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transactions
    • 26 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession to a guarantee and debenture
    Créé le 19 janv. 2009
    Livré le 09 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 9-11 high street, alton, hampshire t/no SH12795, f/h property k/a 139 and 141 manchester road, broadheath, altrincham, cheshire t/no GM768625 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transactions
    • 09 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 19 janv. 2009
    Livré le 31 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other charging company to the chargee and the noteholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all land and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wainford Holdings Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 31 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2009
    • 22 sept. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 25 mars 1998
    Livré le 30 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 49 woodpecker mount and garage 55 addington L.B. of croydon t/n-SGL587114.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 déc. 1997
    Livré le 08 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a 63 bellfield addington london borough of croydon t/no: SGL171383. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 sept. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0