WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03428877 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Lkab Minerals Limited Raynesway DE21 7BE Derby England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Richard Mark Wheatley en tant que secrétaire le 16 août 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Miss Lisa Jane Newbold en tant que secrétaire le 16 août 2021 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2020 | 18 pages | AA | ||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2020 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Lkab Minerals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 sept. 2019 | 2 pages | PSC05 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018 | 10 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de David Thomas Balch en tant que directeur le 28 févr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O the White House Gurney Slade Radstock Radstock BA3 4UU à C/O Lkab Minerals Limited Raynesway Derby DE21 7BE le 14 déc. 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 janv. 2019 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||
Nomination de Mr Richard Mark Wheatley en tant que secrétaire le 03 déc. 2018 | 2 pages | AP03 | ||
Satisfaction de la charge 034288770009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Nomination de Mr Darren Anthony Wilson en tant qu'administrateur le 03 déc. 2018 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Adrian Howard Willmott en tant que directeur le 03 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Jane Symonds Willmott en tant que directeur le 03 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||
Notification de Lkab Minerals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Adrian Howard Willmott en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018 | 1 pages | PSC07 | ||
Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2018 | 11 pages | AA | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2017 | 10 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWBOLD, Lisa Jane | Secrétaire | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | 286278450001 | |||||||
| WILSON, Darren Anthony | Administrateur | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | England | British | 183267820001 | |||||
| ASTLEY, Stephen | Secrétaire | Overnhill Road BS16 5DN Downend 18 Bristol | British | 130826850001 | ||||||
| LUMBER, Nicholas, Acma | Secrétaire | 20 Compton Road BA4 5QR Shepton Mallet Somerset | British | 55404740001 | ||||||
| WHEATLEY, Richard Mark | Secrétaire | Raynesway DE21 7BE Derby C/O Lkab Minerals Limited England | 253101350001 | |||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| ASTLEY, Stephen | Administrateur | Overnhill Road BS16 5DN Downend 18 Bristol | England | British | 130826850001 | |||||
| BALCH, David Thomas | Administrateur | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House England | England | British | 199358570001 | |||||
| LUMBER, Nicholas, Acma | Administrateur | 20 Compton Road BA4 5QR Shepton Mallet Somerset | British | 55404740001 | ||||||
| SMITH, David Peter | Administrateur | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House Somerset United Kingdom | United Kingdom | British | 123036790012 | |||||
| SYMONDS WILLMOTT, Jane | Administrateur | c/o The White House Radstock BA3 4UU Radstock Gurney Slade United Kingdom | England | British | 115812240003 | |||||
| WILLMOTT, Adrian Howard | Administrateur | Gurney Slade BA3 4UU Radstock The White House Somerset United Kingdom | England | British | 18773770004 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Administrateur désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lkab Holdings (Uk) Limited | 03 déc. 2018 | Raynesway DE21 7BE Derby Mica Works England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Adrian Howard Willmott | 06 avr. 2016 | c/o THE WHITE HOUSE Radstock BA3 4UU Radstock Gurney Slade | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 30 juil. 2015 Livré le 03 août 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description The freehold land being euston lime, stretham road, wicken, ely, CB75XL registered at the land registry with title number CB207528. Please see charge for details of further properties. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 08 févr. 2010 Livré le 20 févr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 29 juin 2006 Livré le 01 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land to the north of dimmock's cote road wicken cambridgeshire t/no's CB207528 and CB264899. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 16 mai 2006 Livré le 20 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 25 avr. 2006 Livré le 04 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 sept. 2004 Livré le 22 sept. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 mars 2002 Livré le 16 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/Hh property k/a land to the north of dimmocks cote road wicken cambridgeshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 août 2001 Livré le 29 août 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage | Créé le 30 sept. 1997 Livré le 02 oct. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti £100,000 and all other monies de or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions One saxi frage mill id no. SAXIBMBF01 all accesories component parts improvements renewals all books manuals technical data drawings schedules and other documentation and any amendment thereto. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0