WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED

WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03428877
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Lkab Minerals Limited
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALEXCREST LIMITED03 sept. 199703 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Richard Mark Wheatley en tant que secrétaire le 16 août 2021

    1 pagesTM02

    Nomination de Miss Lisa Jane Newbold en tant que secrétaire le 16 août 2021

    2 pagesAP03

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 juin 2020

    18 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2019 au 30 juin 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2020 avec mises à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Lkab Minerals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 sept. 2019

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    10 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Thomas Balch en tant que directeur le 28 févr. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O the White House Gurney Slade Radstock Radstock BA3 4UU à C/O Lkab Minerals Limited Raynesway Derby DE21 7BE le 14 déc. 2018

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 janv. 2019 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Richard Mark Wheatley en tant que secrétaire le 03 déc. 2018

    2 pagesAP03

    Satisfaction de la charge 034288770009 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Darren Anthony Wilson en tant qu'administrateur le 03 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Adrian Howard Willmott en tant que directeur le 03 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jane Symonds Willmott en tant que directeur le 03 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Notification de Lkab Minerals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018

    2 pagesPSC02

    Cessation de Adrian Howard Willmott en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 déc. 2018

    1 pagesPSC07

    Déclaration de confirmation établie le 22 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2018

    11 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 janv. 2017

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEWBOLD, Lisa Jane
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    Secrétaire
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    286278450001
    WILSON, Darren Anthony
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    Administrateur
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    EnglandBritish183267820001
    ASTLEY, Stephen
    Overnhill Road
    BS16 5DN Downend
    18
    Bristol
    Secrétaire
    Overnhill Road
    BS16 5DN Downend
    18
    Bristol
    British130826850001
    LUMBER, Nicholas, Acma
    20 Compton Road
    BA4 5QR Shepton Mallet
    Somerset
    Secrétaire
    20 Compton Road
    BA4 5QR Shepton Mallet
    Somerset
    British55404740001
    WHEATLEY, Richard Mark
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    Secrétaire
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    C/O Lkab Minerals Limited
    England
    253101350001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    ASTLEY, Stephen
    Overnhill Road
    BS16 5DN Downend
    18
    Bristol
    Administrateur
    Overnhill Road
    BS16 5DN Downend
    18
    Bristol
    EnglandBritish130826850001
    BALCH, David Thomas
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    England
    Administrateur
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    England
    EnglandBritish199358570001
    LUMBER, Nicholas, Acma
    20 Compton Road
    BA4 5QR Shepton Mallet
    Somerset
    Administrateur
    20 Compton Road
    BA4 5QR Shepton Mallet
    Somerset
    British55404740001
    SMITH, David Peter
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    Somerset
    United Kingdom
    Administrateur
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    Somerset
    United Kingdom
    United KingdomBritish123036790012
    SYMONDS WILLMOTT, Jane
    c/o The White House
    Radstock
    BA3 4UU Radstock
    Gurney Slade
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o The White House
    Radstock
    BA3 4UU Radstock
    Gurney Slade
    United Kingdom
    EnglandBritish115812240003
    WILLMOTT, Adrian Howard
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    Somerset
    United Kingdom
    Administrateur
    Gurney Slade
    BA3 4UU Radstock
    The White House
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritish18773770004
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Lkab Holdings (Uk) Limited
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    Mica Works
    England
    03 déc. 2018
    Raynesway
    DE21 7BE Derby
    Mica Works
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement04621769
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Adrian Howard Willmott
    c/o THE WHITE HOUSE
    Radstock
    BA3 4UU Radstock
    Gurney Slade
    06 avr. 2016
    c/o THE WHITE HOUSE
    Radstock
    BA3 4UU Radstock
    Gurney Slade
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    WICKEN LIME AND STONE COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 30 juil. 2015
    Livré le 03 août 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold land being euston lime, stretham road, wicken, ely, CB75XL registered at the land registry with title number CB207528. Please see charge for details of further properties.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC
    Transactions
    • 03 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 04 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 08 févr. 2010
    Livré le 20 févr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 28 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 29 juin 2006
    Livré le 01 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land to the north of dimmock's cote road wicken cambridgeshire t/no's CB207528 and CB264899. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 25 avr. 2006
    Livré le 04 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 04 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2004
    Livré le 22 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 mars 2002
    Livré le 16 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/Hh property k/a land to the north of dimmocks cote road wicken cambridgeshire.
    Personnes ayant droit
    • Sterling Capital Finance PLC
    Transactions
    • 16 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 août 2001
    Livré le 29 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Wales & Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 02 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all other monies de or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    One saxi frage mill id no. SAXIBMBF01 all accesories component parts improvements renewals all books manuals technical data drawings schedules and other documentation and any amendment thereto.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transactions
    • 02 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0