THE HOSPITAL GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | THE HOSPITAL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03429311 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 2nd Floor 107 Cheapside EC2V 6DN London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 sept. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 sept. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 sept. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 11 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 23 pages | AA | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Saltgate (Uk) Limited le 14 nov. 2022 | 1 pages | CH04 | ||
Changement d'adresse du siège social de 27-28 Clement's Lane London EC4N 7AE England à 2nd Floor 107 Cheapside London EC2V 6DN le 14 nov. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 03 nov. 2021
| 3 pages | SH01 | ||
Nomination de Mr Ajaykapoor Harrissing Golam en tant qu'administrateur le 07 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Julian Xavier Withrington en tant qu'administrateur le 07 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Saltgate (Uk) Limited en tant que secrétaire le 07 mars 2022 | 2 pages | AP04 | ||
Changement d'adresse du siège social de 24 Endell Street London WC2H 9HQ à 27-28 Clement's Lane London EC4N 7AE le 29 avr. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 32 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 04 sept. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Cessation de Paul Gardner Allen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 juin 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de la nomination de Robert Seals en tant que directeur le 03 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Gert Billand en tant qu'administrateur le 03 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Alison Grace Ivey en tant que directeur le 03 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Danielle Marie Harper en tant que directeur le 03 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Ian Davies en tant que directeur le 03 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTGATE (UK) LIMITED | Secrétaire | Cheapside, 2nd Floor EC2V 6DN London 107 United Kingdom |
| 192229240001 | ||||||||||
| BILLAND, Gert | Administrateur | 82166 Gräfelfing Munich Freihamer Str. 2 Germany | Germany | German | 284045940001 | |||||||||
| GOLAM, Ajaykapoor Harrissing | Administrateur | Cheapside EC2V 6DN London 2nd Floor 107 England | United Kingdom | British | 295310010001 | |||||||||
| HEISSERER, Stefan | Administrateur | 82166 Gräfelfing Munich Freihamer Str. 2 Germany | Germany | German | 284045560001 | |||||||||
| WITHRINGTON, Julian Xavier | Administrateur | Cheapside EC2V 6DN London 2nd Floor 107 England | United Kingdom | British | 194163810001 | |||||||||
| BATESON, Anne Rosalind | Secrétaire désigné | High Trees Great Holland CO13 0HZ Frinton On Sea Essex | British | 900007490001 | ||||||||||
| DAVIES, Ian | Secrétaire | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | British | 126343570001 | ||||||||||
| KEMP, Robert Jonathan Francis | Secrétaire | Flat 14 17 Broad Court WC2B 5QN London | British | 44063700002 | ||||||||||
| LEIGH JR, Richard | Secrétaire | 5489 170th Place Se Bellevue Wa 98006 Usa | Usa | 87306130001 | ||||||||||
| REED, Angela | Secrétaire | 10 Garston Grove Finchampstead RG40 4YG Wokingham Berkshire | British | 85482680001 | ||||||||||
| SAVOY, William David | Secrétaire | 677-120th Avenue Ne 184 Bellevue Wa 98004 Usa | British | 54993310001 | ||||||||||
| ALLEN, Paul Gardner | Administrateur | 6451 W. Mercer Way Mercer Island Wa 98040 Usa | American | 54993160001 | ||||||||||
| APKARIAN, Gagik | Administrateur | 807 Hillside Drive East Seattle Washington State 98112 Usa | Australian | 97665920003 | ||||||||||
| ARRON, Robert Samuel | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | Usa | American | 132568510001 | |||||||||
| BAGNALD, Carol Lang | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | United Kingdom | British | 240241100001 | |||||||||
| BROWN, Nathaniel | Administrateur | 5546 179th Avenue Se Bellevue Wa 98006 Usa | American | 77184280001 | ||||||||||
| CASKA-WRIGHT, Amber | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | Usa | Australian | 156740650001 | |||||||||
| DAVIES, Ian | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | England | English | 249867900001 | |||||||||
| DIXON, Craig Stephen | Administrateur | Florian House Leatherhead Road KT22 0ET Oxshott Surrey | England | British | 105534460001 | |||||||||
| DUNN, Jeffrey | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | Usa | American | 156740560001 | |||||||||
| FARSI, Hani | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | England | British | 41552990001 | |||||||||
| FLETCHER, Denise Koen | Administrateur | 2800 Elliott Avenue Apt 1428 Seattle Wa 98121 United States | United States | 131829100001 | ||||||||||
| HARPER, Danielle Marie | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | United States | American | 280071320001 | |||||||||
| HART, Sophie | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | England | British | 223712710001 | |||||||||
| HENRY LEPART, Diane Patula | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | United Kingdom | British | 163374220001 | |||||||||
| HUTTON, Richard Ernest | Administrateur | 13 Crescent Key Bellevue 98006-1009 Washington Usa | American | 97665930002 | ||||||||||
| IVEY, Alison Grace | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | United States | American | 280136450001 | |||||||||
| KAZA, Andrew Lee | Administrateur | 108 Esmond Road W4 1JF London | American | 67092200002 | ||||||||||
| KEARLEY, Eric Ronald | Administrateur | The Lodge 106 Aberdeen Park N5 2BA London | British | 98108060001 | ||||||||||
| LAI, Poh Lim | Administrateur désigné | 24 Redwood Drive LU7 0TA Wing Buckinghamshire | British | 900007480001 | ||||||||||
| LEIGH JR, Richard | Administrateur | 5489 170th Place Se Bellevue Wa 98006 Usa | Usa | 87306130001 | ||||||||||
| MCGOWAN, Christopher Dean | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | United States | American | 223724140001 | |||||||||
| MEOLA, Thomas | Administrateur | Endell Street WC2H 9HQ London 24 | Usa | American | 134707420001 | |||||||||
| PATTON, Jo Allen | Administrateur | 6005 77th Avenue Se Mercer Island 98040 Usa | American | 65387820001 | ||||||||||
| PILKINGTON, Helen Sarah | Administrateur | 2 Hillview Makepeace Avenue N6 6EU London | United Kingdom | Irish | 69536980001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hclub Acquico Limited | 03 juin 2021 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Paul Gardner Allen | 06 avr. 2016 | Endell Street WC2H 9HQ London 24 United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE HOSPITAL GROUP LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 10 mai 2019 | 16 nov. 2020 | La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées. |
| 15 oct. 2018 | 10 mai 2019 | La société sait ou a des raisons de croire qu'il existe une personne enregistrable en relation avec la société, mais elle ne l'a pas identifiée. |
| 04 sept. 2016 | 16 nov. 2020 | La société a identifié une personne enregistrable en relation avec la société, mais toutes les informations requises sur cette personne n'ont pas été confirmées. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0