RELAND (WEEDON) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RELAND (WEEDON) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03435816 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RELAND (WEEDON) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RELAND (WEEDON) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RELAND (WEEDON) LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour RELAND (WEEDON) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Ross Brodie en tant que directeur le 31 déc. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Ross Brodie le 22 oct. 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG à Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP le 23 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 15 déc. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Elizabeth Catchpole en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de RELAND (WEEDON) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secrétaire | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147811200001 | |||||||
| SHARP, Giles Henry | Administrateur | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| DIPRE, Remo | Secrétaire | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | British | 35117250001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Secrétaire désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Secrétaire | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secrétaire | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| TAYLOR, David John | Secrétaire | Green Lane TN6 3DG Crowborough Valleyoak East Sussex | British | 136521790001 | ||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Administrateur | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | 62279790001 | |||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Administrateur | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | 62279790001 | |||||
| BURNLEY, John Lewis | Administrateur | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Administrateur | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CURRAN, Paul | Administrateur | Syme Place EH10 5GA Edinburgh 13 Midlothian United Kingdom | Scotland | British | 110978610002 | |||||
| DI CIACCA, Cesidio Martin | Administrateur | 45 Blairston Avenue G71 8SA Bothwell Lanarkshire | Scotland | British | 1267050001 | |||||
| DIPRE, John Vivian | Administrateur | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Administrateur | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOYLE, Betty June | Administrateur désigné | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Administrateur désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| FITZSIMMONS, Neil | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Administrateur | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Administrateur | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Administrateur | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCCABE, Kevin Charles | Administrateur | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||
| MILLIGAN, Michael | Administrateur | 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh Quartermile Two Scotland Scotland | Scotland | British | 153845120001 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Administrateur | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 207729000002 |
RELAND (WEEDON) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A bond and floating charge | Créé le 01 sept. 2009 Livré le 14 sept. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The charged assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement | Créé le 01 sept. 2009 Livré le 14 sept. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 déc. 2008 Livré le 09 janv. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 juil. 2000 Livré le 27 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 21 nov. 1997 Livré le 03 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 nov. 1997 Livré le 03 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0