RELAND (WEEDON) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRELAND (WEEDON) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03435816
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CAVALRY CENTRE LIMITED20 nov. 199720 nov. 1997
    HUNTERMILE LIMITED18 sept. 199718 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Jonathan Ross Brodie en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Ross Brodie le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG à Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP le 23 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 sept. 2015

    État du capital au 07 sept. 2015

    • Capital: GBP 32
    SH01

    Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 15 déc. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2014

    État du capital au 08 sept. 2014

    • Capital: GBP 32
    SH01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Catchpole en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de RELAND (WEEDON) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Secrétaire
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147811200001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Administrateur
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Secrétaire
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    British35117250001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secrétaire désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    TAYLOR, David John
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    Secrétaire
    Green Lane
    TN6 3DG Crowborough
    Valleyoak
    East Sussex
    British136521790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Administrateur
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Administrateur
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Administrateur
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CURRAN, Paul
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    Administrateur
    Syme Place
    EH10 5GA Edinburgh
    13
    Midlothian
    United Kingdom
    ScotlandBritish110978610002
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Administrateur désigné
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Administrateur désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MILLIGAN, Michael
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    2 Lister Square
    EH3 9GL Edinburgh
    Quartermile Two
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritish153845120001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002

    RELAND (WEEDON) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A bond and floating charge
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 14 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each residential obligor and each commercial obligor to any residential secured party and any commercial secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The charged assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 14 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 01 sept. 2009
    Livré le 14 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the each obligor and each residential obligor to any commercial secured party and any residential secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 14 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 sept. 2009
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 09 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2000
    Livré le 27 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 21 nov. 1997
    Livré le 03 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 1997
    Livré le 03 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0