MEDICX LHF LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMEDICX LHF LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03436977
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MEDICX LHF LTD. ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe MEDICX LHF LTD. ?

    Adresse du siège social
    5th Floor, Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MEDICX LHF LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LUNN HEALTHCARE FACILITIES LIMITED18 sept. 199718 sept. 1997
    LUNN HEALTH CARE FACILITIES LIMITED16 sept. 199716 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de MEDICX LHF LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour MEDICX LHF LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 sept. 2019

    13 pagesLIQ03
    A8DYXFIO

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    13 pagesLIQ13
    A8DYXFJ4

    Nomination de Nexus Management Services Limited en tant que secrétaire le 14 mars 2019

    2 pagesAP04
    X81K1LEP

    Nomination de Mr Paul Simon Kent Wright en tant qu'administrateur le 14 mars 2019

    2 pagesAP01
    X81K1KQW

    Nomination de Mr Richard Howell en tant qu'administrateur le 14 mars 2019

    2 pagesAP01
    X81K1KF6

    Nomination de Mr Harry Abraham Hyman en tant qu'administrateur le 14 mars 2019

    2 pagesAP01
    X81K1JVD

    Cessation de la nomination de Iag Limited en tant que directeur le 14 mars 2019

    1 pagesTM01
    X81K1J35

    Cessation de la nomination de International Administration Group (Guernsey) Limited en tant que secrétaire le 14 mars 2019

    1 pagesTM02
    X81K1J2X

    Cessation de la nomination de Mark Andrew Woodall en tant que directeur le 14 mars 2019

    1 pagesTM01
    X81K1IYH

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 janv. 2020 au 31 déc. 2019

    1 pagesAA01
    X81K1IXL

    Changement d'adresse du siège social de 55 Baker Street London W1U 7EU à 5th Floor, Greener House 66-68 Haymarket London SW1Y 4RF le 19 mars 2019

    1 pagesAD01
    X81K1I5L

    Comptes modifiés pour une société dormante jusqu'au 31 janv. 2018

    6 pagesAAMD
    A7I72C69

    Changement d'adresse du siège social de 6th Floor 33 Holborn London EC1N 2HT England à 55 Baker Street London W1U 7EU le 19 oct. 2018

    4 pagesAD01
    A7FUMVDM

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600
    A7FUMVE2

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 sept. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01
    A7FUMVEI

    Déclaration de confirmation établie le 16 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X7EYQSDL

    Modification des détails de Medicx Lhp Ltd. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 sept. 2018

    2 pagesPSC05
    X7ESVGX7

    Notification de Medicx Lhp Ltd. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 sept. 2018

    2 pagesPSC02
    X7ESQ9TK

    Cessation de Medicx Fund Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 sept. 2018

    1 pagesPSC07
    X7ESO8OA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2018

    5 pagesAA
    A7EF5WW0

    Satisfaction de la charge 034369770022 en totalité

    1 pagesMR04
    X7DCFQW8

    Satisfaction de la charge 034369770023 en totalité

    1 pagesMR04
    X7DCFRG9

    Déclaration de confirmation établie le 16 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X6FH2WEJ

    Qui sont les dirigeants de MEDICX LHF LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Secrétaire
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04187765
    57253330002
    HOWELL, Richard
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Administrateur
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Administrateur
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant35560380005
    WRIGHT, Paul Simon Kent
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    Administrateur
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    EnglandBritishSolicitor41977220011
    GREENOUGH, Michael Anthony
    4 Larkhill Drive
    Moorside
    BD19 6JS Cleckheaton
    Secrétaire
    4 Larkhill Drive
    Moorside
    BD19 6JS Cleckheaton
    BritishCs7398870001
    JACKSON, Deborah Ann Clare
    20 Parkside Close
    Meanwood
    LS6 4LZ Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    20 Parkside Close
    Meanwood
    LS6 4LZ Leeds
    West Yorkshire
    British57031290001
    LUNN, Graham
    Prospect House Rigton Hill
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    Secrétaire
    Prospect House Rigton Hill
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    British7398900001
    INTERNATIONAL ADMINISTRATION GROUP (GUERNSEY) LIMITED
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    Secrétaire
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    Forme juridiquePRIVATE LIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleTHE COMPANIES (GUERNSEY) LAW 2008
    Numéro d'enregistrement36305
    123212890003
    EDLIN, Timothy Howard
    34 Hall Bank Drive
    BD16 4BZ Bingley
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Hall Bank Drive
    BD16 4BZ Bingley
    West Yorkshire
    BritishDirector55109180002
    FELDMAN, Stephen Mark, Dr
    Carr Lane
    Thorner
    LS14 3HG Leeds
    The Forge Birkby Hall Farm
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Carr Lane
    Thorner
    LS14 3HG Leeds
    The Forge Birkby Hall Farm
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector44584250002
    GILBERT, Ian Michael
    Parkside House Knaresborough Road
    Follifoot
    HG3 1DT Harrogate
    Administrateur
    Parkside House Knaresborough Road
    Follifoot
    HG3 1DT Harrogate
    EnglandBritishSolicitor54723920004
    GREY, Alan
    12 Grayson House
    Beech Grove
    HG2 0ER Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    12 Grayson House
    Beech Grove
    HG2 0ER Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director40983300003
    HALL, John James
    Silver Birches 20 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Silver Birches 20 Woodlands Green
    HG2 8QD Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector58204100001
    LESTNER, David Andrew
    Hall Green Lane
    North Rigton
    LS17 0DW Leeds
    Grand View
    West Yorkshire
    Administrateur
    Hall Green Lane
    North Rigton
    LS17 0DW Leeds
    Grand View
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director130554510001
    LUNN, Derek
    Moorside House West Winds
    Moor Lane Menston
    LS29 6QD Ilkley
    West Yorkshire
    Administrateur
    Moorside House West Winds
    Moor Lane Menston
    LS29 6QD Ilkley
    West Yorkshire
    BritishDirector47513990002
    LUNN, Graham
    Prospect House Rigton Hill
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    Administrateur
    Prospect House Rigton Hill
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    EnglandBritishDirector7398900001
    LUNN, Roy
    19 Bingley Bank
    Bardsey
    LS17 9DW Leeds
    Administrateur
    19 Bingley Bank
    Bardsey
    LS17 9DW Leeds
    EnglandBritishDirector7398930001
    MAY, Brian Ward
    Church Garth
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    North Yorkshire
    Administrateur
    Church Garth
    Topcliffe
    YO7 3PB Thirsk
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector78419090001
    WOODALL, Mark Andrew
    Verte Rue
    Vale
    GY6 8BP Guernsey
    St Anne
    Channel Islands
    Administrateur
    Verte Rue
    Vale
    GY6 8BP Guernsey
    St Anne
    Channel Islands
    GuernseyBritishCompany Director179218860001
    WRIGHT, Carl Barry
    Leadhall Way
    HG2 9PG Harrogate
    5
    North Yorkshire
    Administrateur
    Leadhall Way
    HG2 9PG Harrogate
    5
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector139343670001
    IAG LIMITED
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    Administrateur
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Channel Islands
    Forme juridiquePRIVATE LIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleTHE COMPANIES (GUERNSEY) LAW 2008
    Numéro d'enregistrement45079
    185877720001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MEDICX LHF LTD. ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor; 33
    England
    11 sept. 2018
    Holborn
    EC1N 2HT London
    6th Floor; 33
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04090487
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Medicx Fund Limited
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Guernsey
    06 avr. 2016
    Glategny Esplanade
    St. Peter Port
    GY1 1WW Guernsey
    Regency Court
    Guernsey
    Oui
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementGuernsey
    Autorité légaleThe Companies (Guernsey) Law, 2008
    Lieu d'enregistrementGuernsey
    Numéro d'enregistrement45397
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    MEDICX LHF LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 déc. 2014
    Livré le 23 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land on the north side of station road wigston t/no.LT453663: the villa medical centre roman road prenton t/no.MS338796 and land on the north side of solvent road havent t/no.SH21163 for more details please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 23 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 oct. 2014
    Livré le 14 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Cromwell road medical centre, cromwell road, grimsby t/no's HS255515 and HS348056. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Prudential Trustee Company Limited (As Security Trustee)
    Transactions
    • 14 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 août 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 11 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from lunn healthcare properties limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H lsnd and buildings on the south side of cromwell road grimsby (being the site of the former infant welfare clinic) t/no HS348056 including all buildings erections and fixtures and fittings (but excluding tenants fixtures and fittings) and fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 11 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 07 juil. 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect of f/h land and buildings on the south side of cromwell road grimsby t/no HS348056 and HS255515.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 07 juil. 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H lsnd and buildings on the south side of cromwell road grimsby t/no HS348056 together with all buildings erections and fixtures and fittings (but excluding tenants fixtures and fittings) and fixed plant and machinery.all monies deposited with the trustee.floating charge the whole of the company's undertaking.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment and charge
    Créé le 07 juil. 2009
    Livré le 15 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title benefit claims under and interest in the development agreement see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 août 2007
    Livré le 31 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 18 oct. 2006
    Livré le 27 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 08 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease in respect of f/h land and surgery premises k/a 252 queens road halifax. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 02 déc. 2004
    Livré le 09 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Surgery premises k/a 252 queens road halifax together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 09 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 22 avr. 2004
    Livré le 23 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease in respest of surgery premises at town street st john's place birkenshaw.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 23 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 22 juil. 2003
    Livré le 23 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as 252 queen's road, halifax, west yorkshire t/no WYK114695.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of assignment
    Créé le 22 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights, titles, benefits and interests, whether present or future, of the company to all moneys from time to time due, owing or incurred to the company under the lease in respect of f/h land and surgery premises at town street, st john's place, birkenshaw. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed being supplemental to a deed of legal charge dated 10 december 2001
    Créé le 22 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage f/h land and surgery premises at town street, birkenshaw including with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon. By way of fixed charge all moneys from time to time deposited with the trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed (being supplemental to a deed of legal charge dated 10 december 2001)
    Créé le 13 mai 2002
    Livré le 15 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from jack lunn holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h parcel of land at east park medical centre, 5 east park road, leeds, t/no WYK307714. Together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 15 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 2002
    Livré le 07 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as land on the southerly side of watling street northwich title number CH467102.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment
    Créé le 10 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by jack lunn holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of jack lunn holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of 173B and 173C spring hall lane,halifax,west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of legal charge
    Créé le 10 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by jack lunn holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of jack lunn holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (I) f/hold land and premises known as 173B and 173C spring hall lane,halifax,west yorkshire being the site of a medical centre and a pharmacy and being part of t/no wyk 573128; (ii) parcel of freehold land on the west side of gibraltar road being part of the premises comprised in t/no wyk 646048; together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 10 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by jack lunn holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of jack lunn holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders (trustee) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of east park medical centre,5 east park rd,leeds,west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental deed
    Créé le 10 déc. 2001
    Livré le 14 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 10TH december 2001
    Brèves mentions
    F/Hold land and premises known as east park medical centre,5 east park rd,leeds,west yorkshire; part t/no wyk 307714;together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery;all monies deposited with the trustee.
    Personnes ayant droit
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 14 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2014L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 08 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 juil. 1998
    Livré le 14 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    44 gibraltar road halifax west yorkshire t/n-WYK573128.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 1997
    Livré le 03 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 oct. 1997
    Livré le 06 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 temple view place and 5 east park leeds west yorkshire t/n-WYK307714.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MEDICX LHF LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 sept. 2018Commencement of winding up
    20 déc. 2019Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Edward Terence Kerr
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0