STOCKFLAG LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | STOCKFLAG LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03437935 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STOCKFLAG LIMITED ?
| Adresse du siège social | Enterprise House Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Kent |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STOCKFLAG LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour STOCKFLAG LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tim Ørting Jørgensen en tant que directeur le 03 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ajoy Hari Karna en tant que directeur le 04 juil. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Tim Ørting Jørgensen en tant qu'administrateur le 04 juil. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Robert Lodge en tant que directeur le 30 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Ajoy Hari Karna en tant qu'administrateur le 30 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 30 juin 2021
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital au 28 juin 2021
| 5 pages | SH19 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 12 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 sept. 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 12 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de STOCKFLAG LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIBLEY, Sarah Leanne | Secrétaire | Enterprise House Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Kent | 197289950001 | |||||||
| WHIBLEY, Sarah Leanne | Administrateur | Enterprise House Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Kent | England | British | 197579800001 | |||||
| BOUTEL, Alan John | Secrétaire | Steart Farm North Marston MK18 3LD Buckingham Buckinghamshire | British | 28733880002 | ||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Secrétaire | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||
| ROGERS, James Julian | Secrétaire | 73 Fairacres Road OX4 1TQ Oxford Oxfordshire | British | 50387640001 | ||||||
| WHITEHEAD, Adrian John, Mr, | Secrétaire | Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent England | British | 83031020003 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| ANGEL, Peter George | Administrateur | 11 Field House Drive OX2 7NT Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 4761510002 | |||||
| ARCHER, Jeffrey Onslow | Administrateur | Westlington House Dinton HP17 8TX Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 55720720001 | |||||
| ARCHER, Marion Yvonne | Administrateur | Westlington House Oxford Road Dinton HP17 8TX Aylesbury Buckinghamshire | British | 3063570002 | ||||||
| BOUTEL, Alan John | Administrateur | Steart Farm North Marston MK18 3LD Buckingham Buckinghamshire | British | 28733880002 | ||||||
| BRAKE, Christopher | Administrateur | Fairlawn House Eyhurst KT20 6JN Kingswood Surrey | United Kingdom | British | 90432200001 | |||||
| DESCHAMPS, Bruno | Administrateur | 14 Brompton Square SW3 2AA London | French | 86579020003 | ||||||
| DRISCOLL, William | Administrateur | Lanscombe House Nun's Walk GU25 4RT Virginia Water Surrey | Irish American | 92975240001 | ||||||
| FEARN, Matthew Robin Cyprian | Administrateur | Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent England | United Kingdom | British | 109155280002 | |||||
| GARLICK, Helen | Administrateur | 6 Lambly Hill GU25 4BF Virginia Water | British | 88752280001 | ||||||
| HARTE, Damian | Administrateur | 29 East Avenue Talbot Wood BH3 7BS Bournemouth Dorset | Irish | 95779320001 | ||||||
| HAYTER, George Anthony | Administrateur | The Old Vicarage Maisemore GL12 8HU Gloucester | United Kingdom | British | 160301340001 | |||||
| HUGHES, Leonard | Administrateur | 50 St Margarets Street ME1 1TU Rochester Kent | British | 52234370002 | ||||||
| JØRGENSEN, Tim Ørting, Mr. | Administrateur | Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent England | England | Danish | 285447210001 | |||||
| KARNA, Ajoy Hari | Administrateur | Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent England | United States | American | 232771480001 | |||||
| LODGE, David Robert | Administrateur | Eureka Science Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent | United Kingdom | British | 164083200001 | |||||
| MCKAY, Francis John | Administrateur | Enterprise House Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Kent | British | 110371430001 | ||||||
| PARKER, Christopher John | Administrateur | 30 Main Street MK17 0RT Mursley Buckinghamshire | United Kingdom | British | 91475230002 | |||||
| PERRY, Nigel Peter | Administrateur | Middle Willow Maidstone Road TN15 8JE St Mary's Platt Kent | British | 101033740001 | ||||||
| PLAYER, Michael Ian | Administrateur | Whitelea Shootersway Lane HP4 3NP Berkamsted Hertfordshire | British | 11860001 | ||||||
| POWER, Ian Derek | Administrateur | 13 Turketel Road CT20 2PA Folkestone Kent | United Kingdom | British | 107471150001 | |||||
| VEALE, Stuart Michael | Administrateur | 34 Galveston Road SW15 2SA London | British | 55936180002 | ||||||
| VENABLES, Paul | Administrateur | 37 Ancastle Green RG9 1TS Henley On Thames Oxfordshire | British | 103911420001 | ||||||
| WHITEHEAD, Adrian John, Mr, | Administrateur | Eureka Business Park TN25 4AG Ashford Enterprise House Kent England | England | British | 83031020003 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STOCKFLAG LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brake Bros Limited | 06 avr. 2016 | Nicholas Road, Eureka Science Park TN25 4AG Ashford Enterprise House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
STOCKFLAG LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 12 nov. 2015 Livré le 16 nov. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 02 nov. 2015 Livré le 03 nov. 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 28 mai 2014 Livré le 11 juin 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 21 nov. 2013 Livré le 29 nov. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture accession deed | Créé le 10 déc. 2007 Livré le 13 déc. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| The global form of deed of accession | Créé le 25 sept. 2002 Livré le 09 oct. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargors to the chargee or any of the other secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge, all its right, title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the material intellectual property, any goodwill and rights in relation to the unca. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 01 déc. 1997 Livré le 12 déc. 1997 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from stockflag limited (the borrower) and m&j seafoods (wholesale) limited (the original subsidiaries) to the chargee under or pursuant to the secured documents (as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0