PCV BRACKNELL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPCV BRACKNELL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03439399
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PCV BRACKNELL LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PCV BRACKNELL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PCV BRACKNELL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FREEHOLD PORTFOLIOS BRACKNELL LIMITED19 sept. 199719 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de PCV BRACKNELL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour PCV BRACKNELL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 17 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 août 2012

    État du capital au 03 août 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Leonard Grose le 18 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Nomination de David Leonard Grose en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alasdair Evans en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Mark Leslau le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Miss Sandra Louise Gumm le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages288a

    Qui sont les dirigeants de PCV BRACKNELL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GUMM, Sandra Louise
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Secrétaire
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Australian57113450003
    GROSE, David Leonard
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    Administrateur
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Cavendish House
    United KingdomBritish120479020002
    GUMM, Sandra Louise
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Administrateur
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    Administrateur
    Cavendish House
    18 Cavendish Square
    W1G 0PJ London
    United KingdomBritish6815470021
    MOUSLEY, Emily Ann
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    Administrateur
    Flat C, 1
    Cranley Gardens, Muswell Hill
    N10 3AA London
    United KingdomBritish155262770001
    LINEOBTAIN LIMITED
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    Secrétaire
    Mountcliff House
    154 Brent Street
    NW4 2DR London
    87536870003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRADY, James Michael
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Cromwell Close
    AL4 9YE St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish3769730001
    BURROWES, David William
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    Administrateur
    60 Westwater Way
    OX11 7TY Didcot
    Oxfordshire
    United KingdomBritish100504300001
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Administrateur
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    EVANS, Alasdair David
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    Administrateur
    8 Copsem Lane
    KT10 9EU Esher
    Treaton Mill
    Surrey
    United KingdomBritish130019430001
    HARROLD, Richard Anthony
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Hill House Farm
    Brandon Parva
    NR9 4DL Norwich
    Norfolk
    British33048780001
    LEWIS, Gavin Andrew
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    10 Penners Gardens
    KT6 6JW Surbiton
    Surrey
    British93017010002
    RITBLAT, James William Jeremy
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    Administrateur
    24 St Petersburgh Place
    W2 4LB London
    EnglandBritish38424950003
    WAGMAN, Colin Barry
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    Administrateur
    North Lodge
    25 Ringwood Avenue
    N2 9NT London
    United KingdomBritish39329840001
    WARE, Robert Thomas Ernest
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    Administrateur
    Woodley Lodge
    Duffield Road
    RG5 4RL Woodley
    Berkshire
    United KingdomBritish4779170003

    PCV BRACKNELL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture between the company (formerly known as freehold portfolios bracknell limited) each chargor and the security trustee
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 21 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whather actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to a). Each senior finance party under each senior finance document; or b). Each mezzanine finance party under each mezzanine finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985.
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutchen Bank, London Branch(As Agent and Trustee for the Senior Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties)
    Transactions
    • 21 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 juil. 1999
    Livré le 20 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies whatsoever due or to become due from each borrower (as defined) and fp financial to each finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft,London Branch,as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 20 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture
    Créé le 30 mars 1999
    Livré le 20 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) (the "agent") under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land k/a westerly point market street bracknell t/no: 3439399. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 20 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 janv. 1999
    Livré le 19 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each borrower (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined)under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land k/a westerly point market street bracknell t/no: BK231197 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transactions
    • 19 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignment by way of charge
    Créé le 03 nov. 1997
    Livré le 18 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest to all monies payable under the occupational lease/s in respect of westerly point market street bracknell berkshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transactions
    • 18 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 nov. 1997
    Livré le 18 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Westerly point market street bracknell berkshire t/n BK231197 together with all buildings and fixtures the benefit of all leases and covenants affecting the same all monies deposited with the trustee. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transactions
    • 18 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0