HARMONY PUB COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARMONY PUB COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03440355
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HERITAGE PUB COMPANY LIMITED07 mars 200307 mars 2003
    THE HERITAGE II PUB COMPANY LIMITED26 sept. 199726 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mai 2015

    8 pages4.68

    Cessation de la nomination de Kevin Georgel en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Glenn Pearson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Clifford en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ* le 05 juin 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution insolvency:re liquidator business & remuneration
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2014

    État du capital au 16 mai 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Satisfaction de la charge 034403550031 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 034403550032 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jonathan Paveley en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 01 juin 2013

    14 pagesAA

    Statuts

    11 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Financing arrangements 26/06/2013
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Inscription de la charge 034403550032

    54 pagesMR01

    Inscription de la charge 034403550031

    88 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 26 mai 2012

    16 pagesAA

    legacy

    5 pagesMG02

    legacy

    6 pagesMG02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Glenn Pearson le 28 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de HARMONY PUB COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BALL, Christopher William
    144 Above Town
    TQ6 9RH Dartmouth
    Devon
    Secrétaire
    144 Above Town
    TQ6 9RH Dartmouth
    Devon
    BritishDirector54813560001
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Secrétaire
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    British62175190001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Secrétaire
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BALL, Christopher William
    144 Above Town
    TQ6 9RH Dartmouth
    Devon
    Administrateur
    144 Above Town
    TQ6 9RH Dartmouth
    Devon
    EnglandBritishDirector54813560001
    BROWN, Aaron Maxwell
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    Administrateur
    11 Carlyle Close
    N2 0QU London
    AmericanDirector98928830001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    FINNEY, Francis David
    Fallowfield
    Barncroft Appleshaw
    SP11 2HD Andover
    Administrateur
    Fallowfield
    Barncroft Appleshaw
    SP11 2HD Andover
    BritishDirector24437950002
    FINNEY, Francis John
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    Administrateur
    Summers End
    8 Weaverlake
    DE13 8AD Yoxall
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector89286280002
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    HARRISON, David John
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    Administrateur
    Main Street
    Winster
    DE4 2DH Matlock
    The Archway
    Derbyshire
    United KingdomBritishChartered Accountant62175190001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Administrateur
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Administrateur
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishCompany Director54137480002
    O'NEILL, John
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    Administrateur
    Westbourne
    Gorse Bank Lane, Baslow
    DE45 1SG Bakewell
    Derbyshire
    BritishCo Director89254470001
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishCompany Director100582600002
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector2541420006
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Administrateur
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritishDirector102593650002
    WILSON, Hugh Wingate
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Home Farm
    Fenton Road Stubton
    NG23 5DB Newark
    Nottinghamshire
    BritishDirector89126810001

    HARMONY PUB COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 12 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 09 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the original property: and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2009
    Livré le 07 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 02 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 01 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of this charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 01 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 2000
    Livré le 30 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the earl manvers public house colwick road nottingham and land and buildings at the south east junction of colwick road and hutton street nottingham t/nos NT327807 and NT125798 and any goodwill plant machinery and fixtures assignment of rental sums proceeds of any property insurance policy and floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods used in connectiion with the property or the business conducted at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 mars 2000
    Livré le 30 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the king william iv public house manvers street nottingham t/n NT20626 and any goodwill plant machinery and fixtures assignment of rental sums proceeds of any property insurance policy and floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods used in connectiion with the property or the business conducted at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 mars 2000
    Livré le 14 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including the squinting cat mansfield road clipstone notts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 14 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 mars 2000
    Livré le 07 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the three horseshoes,middle street,beeston,notts.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 07 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 2000
    Livré le 04 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge over the running horse alfreton road nottingham NG7 3NG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 04 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2000
    Livré le 29 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the royal oak, villa street, beeston, notts NG9 2NY. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 29 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2000
    Livré le 29 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge over the queen's head, breach road, marlpool, derbyshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 29 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 févr. 2000
    Livré le 29 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    First fixed charge over the white lion, swingate, kimberley, notts NG16 2PQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 29 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 déc. 1999
    Livré le 11 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The albert inn woodthorpe road staveley chesterfield derbyshire S43 3BZ and all fixtures fixed plant and machinery vehicles utensils chattels and things goodwill and uncalled capital book debts and other debts floating charge over all undertaking property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 11 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 déc. 1999
    Livré le 09 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The old greyhound inn high street rothwell northamptonshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 09 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 nov. 1999
    Livré le 16 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 16 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 nov. 1999
    Livré le 10 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 10 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 1999
    Livré le 06 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The hatters arms church road warton polesworth warwickshire (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 06 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 sept. 1999
    Livré le 20 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 20 oct. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 août 1999
    Livré le 14 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Park inn,ball haye rd,leek,staffs; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 14 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 juin 1999
    Livré le 25 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific property charged being montagues edward street derby t/no;-DY264643. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mansfield Brewery Trading Limited
    Transactions
    • 25 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    HARMONY PUB COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 mai 2014Commencement of winding up
    15 juin 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0