IMCO RECONOMY 7 LIMITED: Dirigeants
Vue d'ensemble
Nom de la société | IMCO RECONOMY 7 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03441128 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULLIVAN, John | Secrétaire | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210794790001 | |||||||
COX, Paul Anthony | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 153797870001 | ||||
SULLIVAN, John Terence | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Chartered Accountant | 180046340001 | ||||
ALLEN, Caroline Elizabeth | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 207873160001 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
JESKE, Riga | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189289610001 | |||||||
KAHVECI, Suheda | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176234890001 | |||||||
PHILLIPS, Elizabeth Clare | Secrétaire | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
REED, Sophie Catherine Jane | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198173020001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Administrateur | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | Director | 105363350001 | ||||
GERSTROM, Peter Anton | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Company Director | 138719750001 | ||||
HARRISON, Julian John | Administrateur | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | Director | 123927990001 | ||||
HOLL, Alistair Myrie | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | Director | 138014840001 | ||||
JOHNSON, Peter Stuart | Administrateur | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | Director | 11159620001 | ||||
MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Finance Director | 140753960001 | ||||
PHILLIPS, John | Administrateur | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | Company Director | 343070001 | |||||
POLLARD, Charles Nicholas | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Director | 192011710001 | ||||
RIDDLE, David Ellison | Administrateur | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | Director | 556710002 | ||||
STEGGLES, Jonathan David | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 45141530001 | ||||
WARD, Malcolm John | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 57775660003 | ||||
WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Administrateur | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | Director | 92108930002 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0