IMCO RECONOMY 7 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | IMCO RECONOMY 7 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03441128 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Adresse du siège social | Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Shropshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||||||
État du capital au 17 avr. 2018
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 25 juil. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 034411280006 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||
Nomination de Mr John Sullivan en tant que secrétaire le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Llewelyn Milnes-James en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Charles Nicholas Pollard en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Alistair Myrie Holl en tant que directeur le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 21 juil. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Cox en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Ms Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 01 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SULLIVAN, John | Secrétaire | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | 210794790001 | |||||||
COX, Paul Anthony | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Company Director | 153797870001 | ||||
SULLIVAN, John Terence | Administrateur | Stafford Court Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House Shropshire England | England | British | Chartered Accountant | 180046340001 | ||||
ALLEN, Caroline Elizabeth | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 207873160001 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | British | 105363350001 | ||||||
JESKE, Riga | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 189289610001 | |||||||
KAHVECI, Suheda | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 176234890001 | |||||||
PHILLIPS, Elizabeth Clare | Secrétaire | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | 56302980001 | ||||||
REED, Sophie Catherine Jane | Secrétaire | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | 198173020001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Ocean House The Ring RG12 1AN Bracknell Berkshire | 32524900007 | |||||||
DIXON, Sally Veronica | Administrateur | 22 Ardleigh Road N1 4HP London | England | British | Director | 105363350001 | ||||
GERSTROM, Peter Anton | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Company Director | 138719750001 | ||||
HARRISON, Julian John | Administrateur | 24 Havelock Road SY3 7NE Shrewsbury Salop | England | British | Director | 123927990001 | ||||
HOLL, Alistair Myrie | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | Wales | British | Director | 138014840001 | ||||
JOHNSON, Peter Stuart | Administrateur | The Old Post Office Church Road West Peckham ME18 5JL Maidstone Kent | England | British | Director | 11159620001 | ||||
MILNES-JAMES, Richard Llewelyn | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Finance Director | 140753960001 | ||||
PHILLIPS, John | Administrateur | 14 Blackhill Lane WA16 9DR Knutsford Cheshire | British | Company Director | 343070001 | |||||
POLLARD, Charles Nicholas | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | England | British | Director | 192011710001 | ||||
RIDDLE, David Ellison | Administrateur | 3 Lovelace Road KT6 6NS Surbiton Surrey | England | British | Director | 556710002 | ||||
STEGGLES, Jonathan David | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 45141530001 | ||||
WARD, Malcolm John | Administrateur | 2 Coldbath Square London EC1R 5HL | United Kingdom | British | Director | 57775660003 | ||||
WILLACY, Richard Johannes Ormerod | Administrateur | Wraymead 158 Croydon Road RH2 0NG Reigate Surrey | United Kingdom | British | Director | 92108930002 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reconomy (Uk) Limited | 21 juil. 2016 | Stafford Park 1 TF3 3BD Telford Kelsall House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
IMCO RECONOMY 7 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 20 août 2015 Livré le 27 août 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A supplemental common debenture | Créé le 29 nov. 2011 Livré le 08 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 18 mai 2007 Livré le 25 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 avr. 2005 Livré le 11 mai 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 01 mars 1999 Livré le 17 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 mars 1999 Livré le 06 mars 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0