IMCO RECONOMY 7 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIMCO RECONOMY 7 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03441128
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    • Collecte de déchets non dangereux (38110) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kelsall House Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Shropshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WASTE HIRE SERVICES LIMITED08 janv. 199808 janv. 1998
    BROOMCO (1380) LIMITED29 sept. 199729 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    État du capital au 17 avr. 2018

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 23/03/2018
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Changement d'adresse du siège social de 2 Coldbath Square London EC1R 5HL à Kelsall House Stafford Court Stafford Park 1 Telford Shropshire TF3 3BD le 25 juil. 2016

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 034411280006 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Mr John Sullivan en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Llewelyn Milnes-James en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Nicholas Pollard en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alistair Myrie Holl en tant que directeur le 21 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 21 juil. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Terence Sullivan en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Paul Cox en tant qu'administrateur le 21 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    15 pagesAA

    Nomination de Ms Caroline Elizabeth Allen en tant que secrétaire le 01 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SULLIVAN, John
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Secrétaire
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    210794790001
    COX, Paul Anthony
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishCompany Director153797870001
    SULLIVAN, John Terence
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    Administrateur
    Stafford Court
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    Shropshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant180046340001
    ALLEN, Caroline Elizabeth
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    207873160001
    DIXON, Sally Veronica
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    British105363350001
    JESKE, Riga
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    189289610001
    KAHVECI, Suheda
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    176234890001
    PHILLIPS, Elizabeth Clare
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Secrétaire
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    British56302980001
    REED, Sophie Catherine Jane
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Secrétaire
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    198173020001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    Secrétaire
    Ocean House
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Berkshire
    32524900007
    DIXON, Sally Veronica
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    Administrateur
    22 Ardleigh Road
    N1 4HP London
    EnglandBritishDirector105363350001
    GERSTROM, Peter Anton
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishCompany Director138719750001
    HARRISON, Julian John
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    Administrateur
    24 Havelock Road
    SY3 7NE Shrewsbury
    Salop
    EnglandBritishDirector123927990001
    HOLL, Alistair Myrie
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    WalesBritishDirector138014840001
    JOHNSON, Peter Stuart
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    Administrateur
    The Old Post Office
    Church Road West Peckham
    ME18 5JL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishDirector11159620001
    MILNES-JAMES, Richard Llewelyn
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishFinance Director140753960001
    PHILLIPS, John
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    14 Blackhill Lane
    WA16 9DR Knutsford
    Cheshire
    BritishCompany Director343070001
    POLLARD, Charles Nicholas
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    EnglandBritishDirector192011710001
    RIDDLE, David Ellison
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    Administrateur
    3 Lovelace Road
    KT6 6NS Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishDirector556710002
    STEGGLES, Jonathan David
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishDirector45141530001
    WARD, Malcolm John
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    Administrateur
    2 Coldbath Square
    London
    EC1R 5HL
    United KingdomBritishDirector57775660003
    WILLACY, Richard Johannes Ormerod
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    Administrateur
    Wraymead
    158 Croydon Road
    RH2 0NG Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishDirector92108930002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IMCO RECONOMY 7 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Reconomy (Uk) Limited
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    21 juil. 2016
    Stafford Park 1
    TF3 3BD Telford
    Kelsall House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Uk
    Numéro d'enregistrement02951661
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    IMCO RECONOMY 7 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 août 2015
    Livré le 27 août 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 25 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A supplemental common debenture
    Créé le 29 nov. 2011
    Livré le 08 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 25 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (Security Trustee)
    Transactions
    • 25 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 avr. 2005
    Livré le 11 mai 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee in its capacity as security agent for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC
    Transactions
    • 11 mai 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 01 mars 1999
    Livré le 17 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 17 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 mars 1999
    Livré le 06 mars 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • David John Dixonacting for Himself and as Trustee for the Holders of the Loan Notes Being a Series of Up to £400,000 Created by the Company Constituted by a Trust Deed of Even Date Between Company and Chargee
    Transactions
    • 06 mars 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0