TRIBAL NC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRIBAL NC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03442665
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRIBAL NC LIMITED ?

    • Activités de conseil en gestion autres que la gestion financière (70229) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TRIBAL NC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kings Orchard Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRIBAL NC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEWCHURCH LIMITED04 oct. 200004 oct. 2000
    AGORA HEALTHCARE SERVICES LIMITED01 oct. 199701 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de TRIBAL NC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TRIBAL NC LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TRIBAL NC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    État du capital au 28 janv. 2016

    • Capital: GBP 0.01
    4 pagesSH19

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium & other reserves reduced 18/12/2015
    RES13

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Nomination de Mr Robert Charles Garner en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Keith Martin Evans en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2015

    État du capital au 31 mars 2015

    • Capital: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Derrick Breach le 05 juin 2014

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR à Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ le 04 août 2014

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 mars 2014

    État du capital au 31 mars 2014

    • Capital: GBP 17,415,052.29212
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 87-91 Newman Street London W1T 3EY* le 09 mars 2012

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Lorraine Davis en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Certificat de changement de nom

    Company name changed newchurch LIMITED\certificate issued on 24/05/11
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name24 mai 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Dr Keith Martin Evans en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TRIBAL NC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BREACH, Stephen Derrick
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Administrateur
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    EnglandBritish174695940001
    GARNER, Robert Charles
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    Administrateur
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    United KingdomBritish53391420003
    ANDO, Daniella
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    30 Concord Court
    Winery Lane
    KT1 3GF Kingston Upon Thames
    Surrey
    British51693570001
    COLLINS, Richard Hawke
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Secrétaire
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    British136546790001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Secrétaire
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    150939960001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Secrétaire
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    British60400060001
    HERCUS, Ivan Lindsay
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    Secrétaire
    6 Beaumont Crescent
    W14 9LX London
    British116757120001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Secrétaire
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    MANNING, Kingsley Guy
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    Secrétaire
    6 Gatcombe Road
    Tufnell Park
    N19 4PT London
    British15931310001
    WARNER, Evelyn Patricia
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Robin Hill Drive
    GU15 1EG Camberley
    23
    Surrey
    United Kingdom
    British129486480001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secrétaire désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    CONAGHAN, John Edward, Mr.
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    11 Danegeld Place
    PE9 2AF Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish97327390002
    DEWEY, Kevin
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    Administrateur
    Oak Tree Cottage 18 Meadway
    KT10 9HF Esher
    Surrey
    British6631200001
    EVANS, Keith Martin, Dr
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    Administrateur
    Queen Street
    St. Philips
    BS2 0HQ Bristol
    Kings Orchard
    England
    United KingdomBritish159812510001
    FIELD, Andrew
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Administrateur
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish61471170001
    GAMBER, Mark Francis
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    Administrateur
    Erskine Cottage
    Garden Close Givons Grove
    KT22 8LU Leatherhead
    10
    Surrey
    British51105690002
    GODBER, Stephen Alison
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    Administrateur
    41-51 Brighton Road
    RH1 6YS Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish105071600001
    HARMES, David Orlando Spencer
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    10 Lime Walk
    SL6 6QB Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish60400060001
    HINE, Duncan, Dr
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    Administrateur
    Glenrue 6 Butt Lane Close
    LE10 1LF Hinckley
    Leicestershire
    British13396990001
    KANTER, Ralph Thomas Ludwig
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    Administrateur
    Garden Flat
    17 Upper Park Road
    NW3 2UN London
    United KingdomBritish124153720001
    KEY, Simon Robert
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    4 Old Street
    SP4 8JT Salisbury
    Wiltshire
    EnglandBritish41514390002
    KHAN, Junaid
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    Administrateur
    33 The Ridings
    KT11 2PU Cobham
    Surrey
    British98917630001
    LAMBERT, Susan
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    20 Pinel Close
    Virginia Park
    GU25 4SP Virginia Water
    Surrey
    British113974450001
    LAWTON, Simon Marcus
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Administrateur
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish68807890004
    MANNING, Kingsley Guy
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    Administrateur
    22a Jacobs Well Mews
    W1U 3DR London
    United KingdomBritish15931310003
    MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    Administrateur
    123 Mallinson Road
    SW11 1BH London
    British23175310002
    MARTIN, Peter John
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Administrateur
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    EnglandBritish176044430001
    SALLIS, David
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    Administrateur
    42 Sheen Park
    TW9 1UW Richmond
    Surrey
    United KingdomUk44780590002
    SETCHELL, Brenda Carol
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    Administrateur
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United KingdomBritish90477860001
    STONE, Lisa Jane
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    The Grange
    Sandhill Lane, Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    United KingdomBritish69455810002
    TOLLEY, Robyn William
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    Administrateur
    The Old Barn
    Blithbury
    WS15 3JG Rugeley
    Staffordshire
    British95294050001
    TRICKEY, Philip John
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    Administrateur
    Ludshott House Seymour Road
    Headley Down
    GU35 8JX Bordon
    Hampshire
    EnglandBritish72857220001
    WILLIAMS, Richard John
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    Administrateur
    257 Sheen Lane
    SW14 8RN London
    British64882280001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Administrateur désigné
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    TRIBAL NC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rent deposit
    Créé le 05 sept. 2007
    Livré le 11 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The interest bearing sterling deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Laminglade Limited and Laminpark Limited
    Transactions
    • 11 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    All assets debenture
    Créé le 17 sept. 2004
    Livré le 30 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 30 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 févr. 2004
    Livré le 24 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hg Investment Managers Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 2002
    Livré le 18 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited
    Transactions
    • 18 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 juin 2002
    Livré le 02 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All other goodwill in the UK and elsewhere worldwide and the unregistered trade marks and trade names,the core software and the architecture software. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 02 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 04 mai 2001
    Livré le 19 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the beneficiaries under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation from time to time granted
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 19 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 13 sept. 2000
    Livré le 22 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re agora healthcare services limited barclays high interest business account number 30648299. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 sept. 2000
    Livré le 14 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the financial accommodation under the terms of this debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rowan Nominees Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0