RENFREW CHAMBERS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRENFREW CHAMBERS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03445904
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    67 Admiralty Way
    TW11 0NN Teddington
    Middlesex
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONTINENTAL SHELF 94 LIMITED07 oct. 199707 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de * Mulberry House 6 Clare Hill Esher Surrey KT10 9NA* le 17 juil. 2013

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 janv. 2013

    7 pagesAA

    Période comptable actuelle prolongée du 31 oct. 2012 au 31 janv. 2013

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2012

    État du capital au 02 nov. 2012

    • Capital: GBP 3,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Trevor Hugh Spencer le 04 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sonas Holdings Limited le 04 nov. 2009

    2 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Vivian Frederick Nathan le 04 nov. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2008

    9 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2007

    8 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2006

    8 pagesAA

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Qui sont les dirigeants de RENFREW CHAMBERS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SONAS HOLDINGS LIMITED
    Craigwell
    KY13 7NR Kinross
    Not Applicable
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    Craigwell
    KY13 7NR Kinross
    Not Applicable
    Fife
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC127741
    56845640001
    HUDSON, Derek Mccallum
    Craigwell
    KY13 7NR Kinross
    Administrateur
    Craigwell
    KY13 7NR Kinross
    United KingdomBritish1278070001
    NATHAN, Vivian Frederick
    Meridian Heights
    Woodhill
    IRISH Tivoli
    Cork
    Ireland
    Administrateur
    Meridian Heights
    Woodhill
    IRISH Tivoli
    Cork
    Ireland
    United KingdomIrish56988740001
    SPENCER, Trevor Hugh
    Mulberry House
    6 Clare Hill
    KT10 9NA Esher
    Surrey
    Administrateur
    Mulberry House
    6 Clare Hill
    KT10 9NA Esher
    Surrey
    United KingdomBritish36013640004
    MD SECRETARIES LIMITED
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Secrétaire désigné
    C/0 Mcgrigors Llp
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    900005110001
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Administrateur désigné
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    RENFREW CHAMBERS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A standard security which was presented for registration in scotland on 16 may 2003 dated 3 april 2003 and
    Créé le 08 avr. 2003
    Livré le 23 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All and whole the subjects k/a renfrew chambers renfrew street glasgow t/n GLA131858 together with the whole buildings and erections thereon the heritable fixtures and fittings therein and thereon the parts the privileges and pertinents thereof and the borrowers whole right title and interest present and future therein and thereto.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transactions
    • 23 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Assignation of rents
    Créé le 08 mai 2001
    Livré le 11 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a loan agreement dated 3, 10, 18 and 30 january 2001 as defined in the said loan agreement
    Brèves mentions
    All right, title and interest of the company in and to all rents, licence fees, premiums and other payments (including interest payable on those amounts) receivable under all leases at any time and from time to time in renfrew street, glasgow or part of them, including all of the company's rights in respect of payment of the same.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 11 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 avr. 2001
    Livré le 04 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 04 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 25TH april 2001 and dated 22ND march 2001 and
    Créé le 24 mars 2001
    Livré le 09 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in terms of an agreement entered into by the company the bank trvor spencer derek hudson and vivian nathan dated 3,10,18 and 30 january 2001 and any alteration or amendment thereto
    Brèves mentions
    Renfrew chambers renfrew street glasgowgla 131858 all buildings and fixtures th. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 09 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignation
    Créé le 30 nov. 1999
    Livré le 09 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants from time to time under the leases (of basement premises forming part of the subjects known generally as renfrew chambers 18 to 26 renfrew street and 30 renfrew street and 134 to 142 renfield street glasgow). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 09 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture creating fixed and floating charges
    Créé le 03 févr. 1998
    Livré le 18 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 18 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 3 february 1998 and
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The subjects known generally as renfrew chambers,18 to 26 renfrew street and 30 renfrew street and 134 to 142 renfield street,glasgow and comprising all and whole (in the first place) the subjects in the county of the barony and regality of glasgow.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rental assignation
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The company's whole entitlement to receive from each of the tenants from time to time under the leases (of parts of the subjects known generally as renfrew chambers,18 to 26 renfrew street and 30 renfrew street and 134 to 142 renfield street,glasgow) referred to in the paper apart to this form (each as varied,supplemented and/or amended from time to time) (together "the leases") all rents and other sums payable now and in the future in terms of the leases.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0