GOOD INFLUENCE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GOOD INFLUENCE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03449094 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GOOD INFLUENCE LIMITED ?
| Adresse du siège social | PO BOX 70693 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GOOD INFLUENCE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GOOD INFLUENCE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 3 pages | MR04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes complets avec exemption totale modifiés jusqu'au 31 déc. 2017 | 10 pages | AAMD | ||||||||||
legacy | 80 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David Crowther en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Mary Sharp en tant que directeur le 31 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Fiona Mary Sharp le 01 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que secrétaire le 31 mars 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que directeur le 31 mars 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP le 18 févr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GOOD INFLUENCE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROWTHER, David | Administrateur | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | 184391050001 | |||||
| CHARLES, Susan Jane | Secrétaire | Ollatrim 34 Woodfield Hill CR5 3EP Coulsdon Surrey | British | 40366110001 | ||||||
| CONINGTON, Mary Denise | Secrétaire | 17 Rythe Road Claygate KT10 9DG Esher Surrey | British | 39416550001 | ||||||
| DAVISON, Robert Edward | Secrétaire | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | British | 175283600001 | ||||||
| DAVISON, Robert Edward | Secrétaire | Yeomans Close Thorley Park CM23 4EU Bishops Stortford 23 Hertfordshire | British | 45449440002 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Secrétaire désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| EVERITT, David Anthony | Secrétaire | Shorncliffe Lodge Undercliff CT20 3AT Sandgate Kent | British | 33752810001 | ||||||
| TOLLISS, Thomas George | Secrétaire | Curzon Street W1J 5HN London 14 United Kingdom | British | 165540160001 | ||||||
| ANDERSON, Richard James | Administrateur | The White Cottage 4 Thornton Road SW19 4NB Wimbledon | British | 39416370003 | ||||||
| CHAPMAN, Simon Charles, Dr | Administrateur | 15 Westminster Gardens SW1P 4JA London | British | 119295110001 | ||||||
| CHARLES, Susan Jane | Administrateur | Ollatrim 34 Woodfield Hill CR5 3EP Coulsdon Surrey | British | 40366110001 | ||||||
| CONINGTON, Paul Edward Martin | Administrateur | 17 Rythe Road Claygate KT10 9DG Esher Surrey | United Kingdom | British | 141476280002 | |||||
| DAVISON, Robert Edward | Administrateur | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | 45449440002 | |||||
| DIBLE, David James | Administrateur | Church House 118 Trinity Road EH5 3LA Edinburgh Midlothian | British | 72447220001 | ||||||
| DOYLE, Betty June | Administrateur désigné | 8 The Bartons Elstree Hill North WD6 3EN Elstree Herts | British | 900003960001 | ||||||
| DWYER, Daniel John | Administrateur désigné | 6 Brimstone Close Chelsfield Park BR6 7ST Chelsfield Kent | British | 900003970001 | ||||||
| EVERITT, David Anthony | Administrateur | Shorncliffe Lodge Undercliff CT20 3AT Sandgate Kent | British | 33752810001 | ||||||
| HAYHURST, Richard Frank | Administrateur | 19 Riverdale Gardens TW1 2BX East Twickenham Middlesex | British | 15866330003 | ||||||
| KIDDY, Christine Susan | Administrateur | 2 Regents Gate Sarisbury Green SO31 7LB Southampton Hampshire | British | 86197080001 | ||||||
| LEECE, John Henry | Administrateur | 12 Mayfield Road Wimbledon SW19 3NF London | United Kingdom | British | 10904170002 | |||||
| MAHON, Michaela | Administrateur | 2 Righton Close Charvil RG10 9UN Twyford Berkshire | British | 79001260001 | ||||||
| PAYNE, Kevin Jacques | Administrateur | Culmer Corner Culmer Lane GU8 5SP Wormley Surrey | British | 40366170001 | ||||||
| SANDEMAN, Diane Elizabeth | Administrateur | 17 Ravel Close Brighton Hill RG22 4EB Basingstoke Hampshire | British | 48719120001 | ||||||
| SHARP, Fiona Mary | Administrateur | 62 Buckingham Gate SW1P 9ZP London PO BOX 70693 United Kingdom | United Kingdom | British | 66457680002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOOD INFLUENCE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chime Communications Limited | 06 avr. 2016 | Buckingham Gate SW1E 6AJ London 62 England England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GOOD INFLUENCE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 22 août 2012 Livré le 29 août 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 31 mars 2006 Livré le 07 avr. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 06 juin 2002 Livré le 11 juin 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The company with full title guarantee charges £16,000.00 to the chargee. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 26 janv. 2001 Livré le 30 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed | |
Brèves mentions £16,000. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 janv. 1999 Livré le 02 févr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 19 juin 1998 Livré le 23 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined within | |
Brèves mentions The initial deposit of £41,750 and all other monies relative thereto ( the "deposit balance"). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0