GOOD INFLUENCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOOD INFLUENCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03449094
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    PO BOX 70693 62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    1B COMMUNICATIONS LIMITED22 juin 201222 juin 2012
    DE FACTO COMMUNICATIONS LIMITED30 mars 200530 mars 2005
    DE FACTO COMMUNICATIONS PLC30 juil. 200330 juil. 2003
    H.C.C. DE FACTO GROUP PLC08 oct. 199708 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    3 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    3 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name07 mai 2019

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration de confirmation établie le 22 oct. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes complets avec exemption totale modifiés jusqu'au 31 déc. 2017

    10 pagesAAMD

    legacy

    80 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Nomination de Mr David Crowther en tant qu'administrateur le 31 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Fiona Mary Sharp en tant que directeur le 31 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Fiona Mary Sharp le 01 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination d'un secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que secrétaire le 31 mars 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Robert Edward Davison en tant que directeur le 31 mars 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 70693 Southside 105 Victoria Street London SW1P 9ZP à PO Box 70693 62 Buckingham Gate London SW1P 9ZP le 18 févr. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 oct. 2015

    État du capital au 12 oct. 2015

    • Capital: GBP 105,703.2
    SH01

    Qui sont les dirigeants de GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CROWTHER, David
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish184391050001
    CHARLES, Susan Jane
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    Secrétaire
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    British40366110001
    CONINGTON, Mary Denise
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    Secrétaire
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    British39416550001
    DAVISON, Robert Edward
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Secrétaire
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    British175283600001
    DAVISON, Robert Edward
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Yeomans Close
    Thorley Park
    CM23 4EU Bishops Stortford
    23
    Hertfordshire
    British45449440002
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secrétaire désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVERITT, David Anthony
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    Secrétaire
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    British33752810001
    TOLLISS, Thomas George
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    United Kingdom
    Secrétaire
    Curzon Street
    W1J 5HN London
    14
    United Kingdom
    British165540160001
    ANDERSON, Richard James
    The White Cottage
    4 Thornton Road
    SW19 4NB Wimbledon
    Administrateur
    The White Cottage
    4 Thornton Road
    SW19 4NB Wimbledon
    British39416370003
    CHAPMAN, Simon Charles, Dr
    15 Westminster Gardens
    SW1P 4JA London
    Administrateur
    15 Westminster Gardens
    SW1P 4JA London
    British119295110001
    CHARLES, Susan Jane
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    Administrateur
    Ollatrim
    34 Woodfield Hill
    CR5 3EP Coulsdon
    Surrey
    British40366110001
    CONINGTON, Paul Edward Martin
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    Administrateur
    17 Rythe Road
    Claygate
    KT10 9DG Esher
    Surrey
    United KingdomBritish141476280002
    DAVISON, Robert Edward
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish45449440002
    DIBLE, David James
    Church House
    118 Trinity Road
    EH5 3LA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Church House
    118 Trinity Road
    EH5 3LA Edinburgh
    Midlothian
    British72447220001
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Administrateur désigné
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Administrateur désigné
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    EVERITT, David Anthony
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    Administrateur
    Shorncliffe Lodge
    Undercliff
    CT20 3AT Sandgate
    Kent
    British33752810001
    HAYHURST, Richard Frank
    19 Riverdale Gardens
    TW1 2BX East Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    19 Riverdale Gardens
    TW1 2BX East Twickenham
    Middlesex
    British15866330003
    KIDDY, Christine Susan
    2 Regents Gate
    Sarisbury Green
    SO31 7LB Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    2 Regents Gate
    Sarisbury Green
    SO31 7LB Southampton
    Hampshire
    British86197080001
    LEECE, John Henry
    12 Mayfield Road
    Wimbledon
    SW19 3NF London
    Administrateur
    12 Mayfield Road
    Wimbledon
    SW19 3NF London
    United KingdomBritish10904170002
    MAHON, Michaela
    2 Righton Close
    Charvil
    RG10 9UN Twyford
    Berkshire
    Administrateur
    2 Righton Close
    Charvil
    RG10 9UN Twyford
    Berkshire
    British79001260001
    PAYNE, Kevin Jacques
    Culmer Corner
    Culmer Lane
    GU8 5SP Wormley
    Surrey
    Administrateur
    Culmer Corner
    Culmer Lane
    GU8 5SP Wormley
    Surrey
    British40366170001
    SANDEMAN, Diane Elizabeth
    17 Ravel Close
    Brighton Hill
    RG22 4EB Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    17 Ravel Close
    Brighton Hill
    RG22 4EB Basingstoke
    Hampshire
    British48719120001
    SHARP, Fiona Mary
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    Administrateur
    62 Buckingham Gate
    SW1P 9ZP London
    PO BOX 70693
    United Kingdom
    United KingdomBritish66457680002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOOD INFLUENCE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England
    England
    06 avr. 2016
    Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    62
    England
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1983857
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GOOD INFLUENCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 06 juin 2002
    Livré le 11 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company with full title guarantee charges £16,000.00 to the chargee.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 11 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 26 janv. 2001
    Livré le 30 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the rent deposit deed
    Brèves mentions
    £16,000.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 30 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juil. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 1999
    Livré le 02 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 19 juin 1998
    Livré le 23 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined within
    Brèves mentions
    The initial deposit of £41,750 and all other monies relative thereto ( the "deposit balance").
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 23 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0