EDGWARE 174

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEDGWARE 174
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 03452071
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EDGWARE 174 ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques
    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe EDGWARE 174 ?

    Adresse du siège social
    C/O Ascential Group Limited The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EDGWARE 174 ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WORTH GLOBAL STYLE NETWORK LIMITED16 avr. 199816 avr. 1998
    STYLE NETWORK LIMITED20 oct. 199720 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de EDGWARE 174 ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour EDGWARE 174 ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Louise Meads en tant que secrétaire le 06 févr. 2017

    2 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 avr. 2016

    État du capital au 12 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP à C/O Ascential Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP le 14 déc. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2015

    État du capital au 01 avr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 avr. 2014

    État du capital au 01 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Ms Amanda Jane Gradden en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Gulliver en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Greater London House Hampstead Road London NW1 7EJ United Kingdom* le 01 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Emily Gestetner en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de John Keith Gulliver en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de EDGWARE 174 ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOOI, Shanny
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    British129906110001
    MEADS, Louise
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    224385780001
    GRADDEN, Amanda Jane
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director77425910003
    PAINTER, Duncan Anthony
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director132649960001
    ELSDON, Kate
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    Secrétaire
    51 Sackville Crescent
    Harold Wood
    RM3 0EH Romford
    Essex
    British107227940002
    FREEMAN, Susanna
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    173152770001
    HAY, Helen Frances
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    Secrétaire
    MK43 7BB Odell
    The Old Stable Yard
    Beds
    146423790001
    HOGG, Marianne Lisa
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    Secrétaire
    15 Roskell Road
    SW15 1DS London
    BritishSolicitor101383970002
    NAREBOR, Torugbene Eniyekeye
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    Secrétaire
    10 Portland Road
    ME7 2NP Gillingham
    Kent
    British120147010002
    WORTH, Julian Otto
    Willowbrook Old Melton Road
    Normanton On The Wol Keyworth
    NG12 5NH Nottingham
    Secrétaire
    Willowbrook Old Melton Road
    Normanton On The Wol Keyworth
    NG12 5NH Nottingham
    BritishDirector49877690001
    WYNNE THOMAS, Giles Owen
    34 Woodside Road
    TN13 3HF Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    34 Woodside Road
    TN13 3HF Sevenoaks
    Kent
    British69374400003
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    AYDINOGLU, Bozkurt
    Top Floor
    16 Tanza Road
    NW3 2UB London
    Administrateur
    Top Floor
    16 Tanza Road
    NW3 2UB London
    BritishInvestment Banker98940450002
    BAHNS, Robert Harold
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    Administrateur
    40a Parkhill Road
    NW3 2YP London
    BritishBanker64794090001
    BROWN, Philip
    Greydene
    Station Road, Woldingham
    CR3 7DD Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Greydene
    Station Road, Woldingham
    CR3 7DD Caterham
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director70412460002
    CARTER, Derek Raymond Anthony
    Pinewych
    Vigo Road Fairseat
    TN15 7LR Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Pinewych
    Vigo Road Fairseat
    TN15 7LR Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishPublisher29959930002
    ELLIOT, Richard Emmerson
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    Administrateur
    Orchard House
    2 Richardson Close, Mill Drove
    PE10 9YN Bourne
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant40591070005
    GESTETNER, Emily Henrietta
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant138386390001
    GILBERTSON, David Stuart
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director10921820004
    GIROUD, Bernard Philippe
    23 Avenue Emile
    Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Administrateur
    23 Avenue Emile
    Deschanel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FrenchCompany Director74580230001
    GRAY, Tracey Marie
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director130960400002
    GRIFFITHS, Ian Ward
    The Gate House 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE28 2JR Huntingdon
    Administrateur
    The Gate House 1 Rhymers Gate
    Wyton
    PE28 2JR Huntingdon
    United KingdomBritishGroup Finance Director99547790001
    GULLIVER, John Keith
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Top Right Group Limited
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    The Prow
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director170112360001
    HEALEY, Andrew Mark
    37 Lawn Crescent
    Kew
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    Administrateur
    37 Lawn Crescent
    Kew
    TW9 3NS Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishBanker77351950001
    HINDLEY, Martyn John
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    Administrateur
    Hampstead Road
    NW1 7EJ London
    Greater London House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director134332760002
    LITTLEBOY, Ronald Frederick
    71 Barnes High Street
    SW13 9LD London
    Administrateur
    71 Barnes High Street
    SW13 9LD London
    BritishBanker71490330001
    MILLARD, Nik
    Beech End
    Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Beech End
    Woodlands Glade
    HP9 1JZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishAccountant64322000001
    OSTIN, Olav
    Mill Farm
    Beeston Lane, Great Fransham
    NR19 2JF Dereham
    Norfolk
    Administrateur
    Mill Farm
    Beeston Lane, Great Fransham
    NR19 2JF Dereham
    Norfolk
    FrenchVenture Capitalist78752230001
    RONCHI, Giorgio
    Via Serenella 3
    Castagnola
    Switzerland
    Administrateur
    Via Serenella 3
    Castagnola
    Switzerland
    ItalianChairman & Chief Executive Off74037670001
    SMITH, Michael
    1st Floor
    28 Savile Row
    W1S 2EU London
    Administrateur
    1st Floor
    28 Savile Row
    W1S 2EU London
    AmericanCompany Director76912430003
    THOMAS, Henry Carlton
    140 Cottimore Lane
    KT12 2BN Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    140 Cottimore Lane
    KT12 2BN Walton On Thames
    Surrey
    BritishAccountant114612950001
    TISON, Francois
    53 Rue Orfila
    FOREIGN Paris 75020
    France
    Administrateur
    53 Rue Orfila
    FOREIGN Paris 75020
    France
    FrenchInvestment Manager69880760001
    WORTH, Julian Otto
    Pre Des Moines
    Sous Les Vignes 2
    Dully
    1195
    Switzerland
    Administrateur
    Pre Des Moines
    Sous Les Vignes 2
    Dully
    1195
    Switzerland
    BritishCompany Director49877690008
    WORTH, Marcus Daniel
    6 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    Administrateur
    6 Linnell Drive
    NW11 7LJ London
    BritishCompany Director17045840006
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EDGWARE 174 ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    The Prow
    1 Wilder Walk
    W1B 5AP London
    C/O Ascential Group Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04858491
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    EDGWARE 174 a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgages of assurance policies
    Créé le 13 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy dated 26 march 1999 over the life of julian otto worth assuring the sum of £650,000WITH policy no: 9A6871V together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgages of assurance policies
    Créé le 13 nov. 2003
    Livré le 20 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy dated 26 march 1999 over the life of marcus daniel worth assuring the sum of £650,000 with policy no: 9A6877H together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transactions
    • 20 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 nov. 2003
    Livré le 19 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa-Nv UK Branch
    Transactions
    • 19 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 févr. 1999
    Livré le 11 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 11 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rent deposit dated 19/5/98 between the company and heat seal (textiles) limited
    Créé le 22 mai 1998
    Livré le 09 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations of the company,formerly known as style network limited,("the tenant") to the chargee under a lease dated 22ND may 1998 and all other obligations due under this deed
    Brèves mentions
    Sum of £21,500 plus vat and any other sums from time to time deposited by the tenant in a separate designated deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Rank Nemo (Gc) Limited
    Transactions
    • 09 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mai 1998
    Livré le 28 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0