EDGWARE 174
Vue d'ensemble
Nom de la société | EDGWARE 174 |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société privée à responsabilité illimitée |
Numéro de société | 03452071 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EDGWARE 174 ?
Adresse du siège social | C/O Ascential Group Limited The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EDGWARE 174 ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour EDGWARE 174 ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Louise Meads en tant que secrétaire le 06 févr. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Top Right Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP à C/O Ascential Group Limited the Prow 1 Wilder Walk London W1B 5AP le 14 déc. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Nomination de Ms Amanda Jane Gradden en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Gulliver en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Greater London House Hampstead Road London NW1 7EJ United Kingdom* le 01 nov. 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Susanna Freeman en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emily Gestetner en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de John Keith Gulliver en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 2 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EDGWARE 174 ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOOI, Shanny | Secrétaire | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | British | 129906110001 | ||||||
MEADS, Louise | Secrétaire | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | 224385780001 | |||||||
GRADDEN, Amanda Jane | Administrateur | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | England | British | Company Director | 77425910003 | ||||
PAINTER, Duncan Anthony | Administrateur | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | England | British | Company Director | 132649960001 | ||||
ELSDON, Kate | Secrétaire | 51 Sackville Crescent Harold Wood RM3 0EH Romford Essex | British | 107227940002 | ||||||
FREEMAN, Susanna | Secrétaire | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | 173152770001 | |||||||
HAY, Helen Frances | Secrétaire | MK43 7BB Odell The Old Stable Yard Beds | 146423790001 | |||||||
HOGG, Marianne Lisa | Secrétaire | 15 Roskell Road SW15 1DS London | British | Solicitor | 101383970002 | |||||
NAREBOR, Torugbene Eniyekeye | Secrétaire | 10 Portland Road ME7 2NP Gillingham Kent | British | 120147010002 | ||||||
WORTH, Julian Otto | Secrétaire | Willowbrook Old Melton Road Normanton On The Wol Keyworth NG12 5NH Nottingham | British | Director | 49877690001 | |||||
WYNNE THOMAS, Giles Owen | Secrétaire | 34 Woodside Road TN13 3HF Sevenoaks Kent | British | 69374400003 | ||||||
YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
AYDINOGLU, Bozkurt | Administrateur | Top Floor 16 Tanza Road NW3 2UB London | British | Investment Banker | 98940450002 | |||||
BAHNS, Robert Harold | Administrateur | 40a Parkhill Road NW3 2YP London | British | Banker | 64794090001 | |||||
BROWN, Philip | Administrateur | Greydene Station Road, Woldingham CR3 7DD Caterham Surrey | United Kingdom | British | Finance Director | 70412460002 | ||||
CARTER, Derek Raymond Anthony | Administrateur | Pinewych Vigo Road Fairseat TN15 7LR Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Publisher | 29959930002 | ||||
ELLIOT, Richard Emmerson | Administrateur | Orchard House 2 Richardson Close, Mill Drove PE10 9YN Bourne Lincolnshire | United Kingdom | British | Accountant | 40591070005 | ||||
GESTETNER, Emily Henrietta | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 138386390001 | ||||
GILBERTSON, David Stuart | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 10921820004 | ||||
GIROUD, Bernard Philippe | Administrateur | 23 Avenue Emile Deschanel FOREIGN Paris 75007 France | French | Company Director | 74580230001 | |||||
GRAY, Tracey Marie | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | Company Director | 130960400002 | ||||
GRIFFITHS, Ian Ward | Administrateur | The Gate House 1 Rhymers Gate Wyton PE28 2JR Huntingdon | United Kingdom | British | Group Finance Director | 99547790001 | ||||
GULLIVER, John Keith | Administrateur | c/o Top Right Group Limited 1 Wilder Walk W1B 5AP London The Prow United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 170112360001 | ||||
HEALEY, Andrew Mark | Administrateur | 37 Lawn Crescent Kew TW9 3NS Richmond Surrey | United Kingdom | British | Banker | 77351950001 | ||||
HINDLEY, Martyn John | Administrateur | Hampstead Road NW1 7EJ London Greater London House United Kingdom | England | British | Finance Director | 134332760002 | ||||
LITTLEBOY, Ronald Frederick | Administrateur | 71 Barnes High Street SW13 9LD London | British | Banker | 71490330001 | |||||
MILLARD, Nik | Administrateur | Beech End Woodlands Glade HP9 1JZ Beaconsfield Buckinghamshire | British | Accountant | 64322000001 | |||||
OSTIN, Olav | Administrateur | Mill Farm Beeston Lane, Great Fransham NR19 2JF Dereham Norfolk | French | Venture Capitalist | 78752230001 | |||||
RONCHI, Giorgio | Administrateur | Via Serenella 3 Castagnola Switzerland | Italian | Chairman & Chief Executive Off | 74037670001 | |||||
SMITH, Michael | Administrateur | 1st Floor 28 Savile Row W1S 2EU London | American | Company Director | 76912430003 | |||||
THOMAS, Henry Carlton | Administrateur | 140 Cottimore Lane KT12 2BN Walton On Thames Surrey | British | Accountant | 114612950001 | |||||
TISON, Francois | Administrateur | 53 Rue Orfila FOREIGN Paris 75020 France | French | Investment Manager | 69880760001 | |||||
WORTH, Julian Otto | Administrateur | Pre Des Moines Sous Les Vignes 2 Dully 1195 Switzerland | British | Company Director | 49877690008 | |||||
WORTH, Marcus Daniel | Administrateur | 6 Linnell Drive NW11 7LJ London | British | Company Director | 17045840006 | |||||
YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EDGWARE 174 ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wgsn Limited | 06 avr. 2016 | The Prow 1 Wilder Walk W1B 5AP London C/O Ascential Group Limited United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
EDGWARE 174 a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Mortgages of assurance policies | Créé le 13 nov. 2003 Livré le 20 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The policy dated 26 march 1999 over the life of julian otto worth assuring the sum of £650,000WITH policy no: 9A6871V together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgages of assurance policies | Créé le 13 nov. 2003 Livré le 20 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The policy dated 26 march 1999 over the life of marcus daniel worth assuring the sum of £650,000 with policy no: 9A6877H together with all bonuses and other moneys benefits and advantages. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 13 nov. 2003 Livré le 19 nov. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 10 févr. 1999 Livré le 11 févr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of rent deposit dated 19/5/98 between the company and heat seal (textiles) limited | Créé le 22 mai 1998 Livré le 09 juin 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations of the company,formerly known as style network limited,("the tenant") to the chargee under a lease dated 22ND may 1998 and all other obligations due under this deed | |
Brèves mentions Sum of £21,500 plus vat and any other sums from time to time deposited by the tenant in a separate designated deposit account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 20 mai 1998 Livré le 28 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0