GATEWAY OFFSITE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGATEWAY OFFSITE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03453040
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GATEWAY OFFSITE LTD ?

    • (7499) /

    Où se situe GATEWAY OFFSITE LTD ?

    Adresse du siège social
    Unicorn House Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GATEWAY OFFSITE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITSPACE HOTELS LIMITED09 déc. 200809 déc. 2008
    GATEWAY FABRICATIONS LIMITED29 déc. 199729 déc. 1997
    TALKTOP LIMITED21 oct. 199721 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de GATEWAY OFFSITE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour GATEWAY OFFSITE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Matthew Cowan en tant que secrétaire le 30 sept. 2011

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Cessation de la nomination de Ian Sherriff en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Matthew Cowan en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Second Floor 77 Kingsway London WC2B 6SR United Kingdom le 28 juin 2011

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Unicorn House Broad Lane Gilberdyke Brough East Yorkshire HU15 2TS le 27 juin 2011

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de James Bradney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Christopher Harris en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Terence Jackson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de James Bradney en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Christopher John Huckle en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 oct. 2010

    État du capital au 26 oct. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2010

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Ian Sherriff en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Stephen Clarke en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    12 pagesAA

    legacy

    11 pagesMG01

    legacy

    5 pagesMG01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de GATEWAY OFFSITE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRIS, David Christopher
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish76088090001
    HUCKLE, Christopher John
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141831160001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Secrétaire
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    British63261140001
    CLARKE, Stephen
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    British122285190001
    COWAN, Matthew
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Broad Lane
    Gilberdyke
    HU15 2TS Brough
    Unicorn House
    East Yorkshire
    United Kingdom
    161230490001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Secrétaire
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    British19792670001
    HORNCASTLE, Carole Diane
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Beech Hill House
    Beech Hill Road, Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    East Yorkshire
    British79178970001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Secrétaire
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Secrétaire
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SHERRIFF, Ian
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    Barmby-On-The-Marsh
    DN14 7HS Goole
    Grey Dene
    North Humberside
    United Kingdom
    149407420001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ATKINSON, Stewart Martin
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Springwell 32 Bondend Road
    Upton St Leonards
    GL4 8DY Gloucester
    Gloucestershire
    EnglandBritish100469640001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BALL, Martin John
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    Administrateur
    Sandwood House
    Ashfield
    LE15 6QB Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish63261140001
    BEALES, Stuart Patrick
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    Administrateur
    Spring Road
    Market Weighton
    YO43 3JE York
    28
    North Yorkshire
    United KingdomBritish136886810001
    BRADNEY, James
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    Administrateur
    Unicorn House
    Broad Lane
    HU15 2TS Gilberdyke Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish161101450001
    CLARK, William Angus
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    Administrateur
    Folds Head Close
    Folds Head, Calver
    S32 3XJ Hope Valley
    Derbyshire
    British80223540001
    FARMERY, Michael David
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    Administrateur
    26 Crawshaw Avenue
    HU17 7QW Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish19792670001
    HARRIS, David Christopher
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    Administrateur
    35 Carter Drive
    HU17 9GL Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritish76088090001
    HORNCASTLE, Andrew Nigel
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    Administrateur
    Beech Hill House
    Beech Hill Road Swanland
    HU14 3QY North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish4456360002
    JACKSON, Terence William
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    Administrateur
    Beech Hill Road
    HU14 3QY Swanland
    The Hollies 7
    East Yorkshire
    UkBritish132410210001
    MCCANN, Leah
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    Administrateur
    Flat 2 Merchants Warehouse
    Robinson Row
    HU1 2QX Hull
    East Yorkshire
    British51908280001
    NEWTON, Christopher John Landsborough
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Old Brewery
    Main Street
    YO61 2NS Helperby
    North Yorkshire
    British101779200001
    SCANLAN, Sarah Rebecca
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    Administrateur
    26 Northfield Avenue
    Hessle
    HU13 9DL Hull
    North Humberside
    British55408650001
    TAYLOR, Malcolm
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    Administrateur
    9 Copper Beech Close
    Dunnington
    YO19 5PY York
    North Yorkshire
    EnglandBritish83888440001
    TREBBLE, Stephen Paul
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    Administrateur
    The Laurels
    Main Street
    DN22 8DT Bothamsall
    Nottinghamshire
    EnglandBritish76640730001
    WHITE, Norman
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    Administrateur
    19 Burnby Lane
    Pocklington
    YO42 2QB York
    North Yorkshire
    British29472760001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    GATEWAY OFFSITE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 nov. 2009
    Livré le 20 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 16 nov. 2009
    Livré le 20 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 06 nov. 2009
    Livré le 18 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited
    Transactions
    • 18 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 oct. 2008
    Livré le 18 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any company to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited as Agent and Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transactions
    • 18 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 sept. 2002
    Livré le 19 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Northern Venture Managers Limited
    Transactions
    • 19 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 12 sept. 2002
    Livré le 19 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company and by any other company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 17 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Fixed and floating charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 06 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Horncastle Group PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0