RWM DORSET LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RWM DORSET LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03454792 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RWM DORSET LIMITED ?
| Adresse du siège social | Harlescott Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Shropshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RWM DORSET LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour RWM DORSET LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Janet Jennings en tant que secrétaire le 02 avr. 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2019 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 01 avr. 2018 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 30 avr. 2018 | 2 pages | PSC09 | ||||||||||
Notification de Rwm Food Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 02 avr. 2017 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 27 mars 2016 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thomas Francis Stephenson en tant que directeur le 16 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Thomas Francis Stephenson en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 29 mars 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RWM DORSET LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JENNINGS, Janet | Secrétaire | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire | 282226050001 | |||||||
| MCLAUGHLIN, John | Secrétaire | Rock Court Blackrock 9 County Louth Northern Ireland | 164135890001 | |||||||
| BURTON, John Michael | Administrateur | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | England | British | 158694740001 | |||||
| KIRWAN, Thomas Joseph Lawrence, Mr. | Administrateur | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | England | Irish | 53766120001 | |||||
| MICHAU, Peter James | Secrétaire | 3 Littleworth Lane KT10 9PF Esher Lessworth Surrey | British | 35521130001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
| COBDEN, Matthew Halsted | Administrateur | Whitcombe Farm Ash TA12 6AH Martock Somerset | England | British | 35792480002 | |||||
| COBDEN, William Noel Halstead | Administrateur | The Westover Bungalow Whitcombe Farm TA12 6AH Martock Somerset | British | 78312910001 | ||||||
| EASTWOOD, Mark | Administrateur | 68 Marsh Lane BA21 3BY Yeovil Somerset | England | British | 105113870002 | |||||
| FINNERTY, Paul John | Administrateur | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | Ireland | Irish | 138964760001 | |||||
| HEFFER, Graham Keith | Administrateur | 14 Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | 118776840001 | |||||
| HEFFER, Henry Robin | Administrateur | Penthouse C 82 Lilliput Rd BH14 8LA Poole Forsyte Shades Dorset | United Kingdom | British | 49020560002 | |||||
| HEFFER, Robert Paul | Administrateur | Mulberry House Laurel Drive BH18 8LJ Broadstone Dorset | United Kingdom | British | 49020570001 | |||||
| MURPHY, David | Administrateur | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire United Kingdom | Ireland | Irish | 164125330001 | |||||
| STEPHENSON, Thomas Francis | Administrateur | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury Harlescott Shropshire | Ireland | Irish | 217150530001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RWM DORSET LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rwm Food Group Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Battlefield Road SY1 4AH Shrewsbury . United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour RWM DORSET LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 24 oct. 2016 | 06 mars 2018 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
RWM DORSET LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 09 août 2011 Livré le 19 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 juil. 2010 Livré le 21 juil. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Créé le 14 juil. 2010 Livré le 15 juil. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 31 oct. 2007 Livré le 01 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1000000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions New lamb slaughtering line s/n WP60071 & WP60072. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 16 nov. 2006 Livré le 17 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Reiser UK LTD supervac GK812B & AT15E robins hawkins engineering LTD effluent plant WT50093-50096. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 05 août 2003 Livré le 16 août 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The chattels the figa-bohn refridgeration equipment type PO73088/PP03814 (a) 2 x coolers SOP0015822 (a) SOP0015915 (a) 2 x condensing units SOP0015822(b) SOPP0015975(b), for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattel mortgage | Créé le 30 avr. 1999 Livré le 05 mai 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti £104,400 and all other monies due or to become due from he company to the chargee under the terms of the mortgage | |
Brèves mentions 1 x wbm 1350 conveyor vacuum packer with 1250 booster busch pump with serial no.6012HA110., 1 x stbw 60/80 electric shrink tunnel (72HA1606)., 1 x opal 6M conveyor and electrical control (OPD44779)., 1 x opal 1M conveyor and electrical control (A.22)., 1 x opal 3 tier packing container (A.33)., 1X opal 2M conveyor & electrical control no. Opo 44899., 1 x opal overhead roller track (A.11)., 1 x opal beef cutting line (A00). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 02 févr. 1999 Livré le 08 févr. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a the abbattoir chetnole road yetminster dorset t/no DT250109. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 01 mai 1998 Livré le 13 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0