RWM DORSET LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRWM DORSET LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03454792
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RWM DORSET LIMITED ?

    • Transformation et conservation de la viande (10110) / Industries manufacturières

    Où se situe RWM DORSET LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Harlescott
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Shropshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RWM DORSET LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROMFORD WHOLESALE MEATS (DORSET) LIMITED20 nov. 199720 nov. 1997
    BROOMCO (1400) LIMITED24 oct. 199724 oct. 1997

    Quels sont les derniers comptes de RWM DORSET LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour RWM DORSET LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Nomination de Mrs Janet Jennings en tant que secrétaire le 02 avr. 2021

    2 pagesAP03

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 01 avr. 2018

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 30 avr. 2018

    2 pagesPSC09

    Notification de Rwm Food Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Comptes pour une petite entreprise établis au 02 avr. 2017

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 27 mars 2016

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Thomas Francis Stephenson en tant que directeur le 16 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Thomas Francis Stephenson en tant qu'administrateur le 30 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 24 oct. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul John Finnerty en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 29 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 nov. 2015

    État du capital au 02 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 oct. 2014

    État du capital au 28 oct. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de RWM DORSET LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JENNINGS, Janet
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    Secrétaire
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    282226050001
    MCLAUGHLIN, John
    Rock Court
    Blackrock
    9
    County Louth
    Northern Ireland
    Secrétaire
    Rock Court
    Blackrock
    9
    County Louth
    Northern Ireland
    164135890001
    BURTON, John Michael
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandBritish158694740001
    KIRWAN, Thomas Joseph Lawrence, Mr.
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    EnglandIrish53766120001
    MICHAU, Peter James
    3 Littleworth Lane
    KT10 9PF Esher
    Lessworth
    Surrey
    Secrétaire
    3 Littleworth Lane
    KT10 9PF Esher
    Lessworth
    Surrey
    British35521130001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Secrétaire désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    COBDEN, Matthew Halsted
    Whitcombe Farm
    Ash
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    Administrateur
    Whitcombe Farm
    Ash
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    EnglandBritish35792480002
    COBDEN, William Noel Halstead
    The Westover Bungalow
    Whitcombe Farm
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    Administrateur
    The Westover Bungalow
    Whitcombe Farm
    TA12 6AH Martock
    Somerset
    British78312910001
    EASTWOOD, Mark
    68 Marsh Lane
    BA21 3BY Yeovil
    Somerset
    Administrateur
    68 Marsh Lane
    BA21 3BY Yeovil
    Somerset
    EnglandBritish105113870002
    FINNERTY, Paul John
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    IrelandIrish138964760001
    HEFFER, Graham Keith
    14 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Administrateur
    14 Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritish118776840001
    HEFFER, Henry Robin
    Penthouse C
    82 Lilliput Rd
    BH14 8LA Poole
    Forsyte Shades
    Dorset
    Administrateur
    Penthouse C
    82 Lilliput Rd
    BH14 8LA Poole
    Forsyte Shades
    Dorset
    United KingdomBritish49020560002
    HEFFER, Robert Paul
    Mulberry House
    Laurel Drive
    BH18 8LJ Broadstone
    Dorset
    Administrateur
    Mulberry House
    Laurel Drive
    BH18 8LJ Broadstone
    Dorset
    United KingdomBritish49020570001
    MURPHY, David
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    United Kingdom
    IrelandIrish164125330001
    STEPHENSON, Thomas Francis
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    Administrateur
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    Harlescott
    Shropshire
    IrelandIrish217150530001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Administrateur désigné
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RWM DORSET LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Rwm Food Group Holdings Limited
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    .
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Battlefield Road
    SY1 4AH Shrewsbury
    .
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement6107425
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour RWM DORSET LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    24 oct. 201606 mars 2018La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    RWM DORSET LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 09 août 2011
    Livré le 19 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2010
    Livré le 21 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 14 juil. 2010
    Livré le 15 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 31 oct. 2007
    Livré le 01 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1000000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    New lamb slaughtering line s/n WP60071 & WP60072.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 16 nov. 2006
    Livré le 17 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Reiser UK LTD supervac GK812B & AT15E robins hawkins engineering LTD effluent plant WT50093-50096.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 17 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 05 août 2003
    Livré le 16 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The chattels the figa-bohn refridgeration equipment type PO73088/PP03814 (a) 2 x coolers SOP0015822 (a) SOP0015915 (a) 2 x condensing units SOP0015822(b) SOPP0015975(b), for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 16 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 30 avr. 1999
    Livré le 05 mai 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £104,400 and all other monies due or to become due from he company to the chargee under the terms of the mortgage
    Brèves mentions
    1 x wbm 1350 conveyor vacuum packer with 1250 booster busch pump with serial no.6012HA110., 1 x stbw 60/80 electric shrink tunnel (72HA1606)., 1 x opal 6M conveyor and electrical control (OPD44779)., 1 x opal 1M conveyor and electrical control (A.22)., 1 x opal 3 tier packing container (A.33)., 1X opal 2M conveyor & electrical control no. Opo 44899., 1 x opal overhead roller track (A.11)., 1 x opal beef cutting line (A00). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 05 mai 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 02 févr. 1999
    Livré le 08 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the abbattoir chetnole road yetminster dorset t/no DT250109. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 08 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 mai 1998
    Livré le 13 mai 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 08 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0