QUILTER PERIMETER LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | QUILTER PERIMETER LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03456361 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| Adresse du siège social | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 févr. 2027 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 23 févr. 2027 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 09 févr. 2026 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2026 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 26 pages | AA | ||||||||||
legacy | 182 pages | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 09 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Skandia Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 déc. 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed old mutual financial services(uk)LIMITED\certificate issued on 22/12/21 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2021 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 28 sept. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Quilter Cosec Services Limited le 14 sept. 2020 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des détails de Skandia Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 sept. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Millennium Bridge House 2 Lambeth Hill London EC4V 4AJ United Kingdom à Senator House 85 Queen Victoria Street London EC4V 4AB le 14 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 févr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUILTER COSEC SERVICES LIMITED | Secrétaire | 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London Senator House United Kingdom |
| 238710730002 | ||||||||||
| EARDLEY, Duncan John Lane | Administrateur | 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London Senator House United Kingdom | United Kingdom | British | 136435020001 | |||||||||
| LEE-CROSSETT, Kevin Stephen | Administrateur | 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London Senator House United Kingdom | United Kingdom | American | 192267060002 | |||||||||
| SATCHEL, Mark Oscar | Administrateur | 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London Senator House United Kingdom | United Kingdom | British,South African | 71956170006 | |||||||||
| BATTY, Adam | Secrétaire | Flat 6 40 Carlton Drive Putney SW15 2DG London | British | 64653110002 | ||||||||||
| FORSYTHE, Paul | Secrétaire | 2 Lambeth Hill EC4V 4GG London 5th Floor Millennium Bridge House United Kingdom | British | 112400030002 | ||||||||||
| LAW, Robert David | Secrétaire | 1 Chatsworth Grove Folly Hill GU9 0DJ Farnham Surrey | British | 50487940001 | ||||||||||
| MARQUARD, Brian Andrew | Secrétaire | Thornhill Stockton Avenue GU13 8NS Fleet Hampshire | British | 69776400002 | ||||||||||
| MURRAY, Martin Charles | Secrétaire | Flat 3 The Old Sorting Office 37 Station Road Barnes SW13 0LF London | British | 34484270003 | ||||||||||
| SUTTON, Ian Nicholas | Secrétaire | 83a Hervey Road Blackheath SE3 8BX London | British | 37516040002 | ||||||||||
| TELFER, Miranda Lauraine | Secrétaire | Lingfield House East Grinstead RH7 6ES Lingfield | British | 80083220001 | ||||||||||
| WALLIS, Nicholas Charles | Secrétaire | 35 Woodstock Road North AL1 4QD St Albans Hertfordshire | British | 4190770001 | ||||||||||
| WARR, Mark Robert | Secrétaire | Flat 17, Yew Tree House 19-23 Hook Road KT6 5AA Surbiton Surrey | British | 68147240001 | ||||||||||
| THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Secrétaire désigné | Leonard Street EC2A 4QS London 83 | 900013740001 | |||||||||||
| AINSWORTH, Anthony John | Administrateur | Oak Lodge 15 Heathgate Wickham Bishops CM8 3NZ Witham Essex | British | 55153850002 | ||||||||||
| ANSTEE, Eric Edward | Administrateur | Whitethorns Weydown Road GU27 1DS Haslemere Surrey | United Kingdom | British | 76479900001 | |||||||||
| ASKARI, Hasan | Administrateur | 22 Ovington Square SW3 1LR London | United Kingdom | British | 41444890001 | |||||||||
| BATTY, Adam | Administrateur | Flat 6 40 Carlton Drive Putney SW15 2DG London | British | 64653110002 | ||||||||||
| BERNAYS, Richard Oliver | Administrateur | 82 Elgin Crescent W11 2JL London | United Kingdom | British | 98729980001 | |||||||||
| BICKET, Nicholas Albert | Administrateur | Ledbrough Gate HP9 1DQ Beaconsfield Cleeve House 9 Buckinghamshire | United Kingdom | British | 146686150001 | |||||||||
| BLATCHLY, Christopher Nigel | Administrateur | Old Comptons Comptons Lane RH13 6DP Horsham West Sussex | British | 26871210002 | ||||||||||
| BOOTHMAN, Clive Nicholas | Administrateur | 28 Baskerville Road SW18 3RS London | British | 24493710001 | ||||||||||
| BROADHURST, Norman Neill | Administrateur | Hobroyd Penny Bridge LA12 7TD Ulverston Cumbria | England | British | 49021680001 | |||||||||
| CAMPBELL, Colin Robert | Administrateur | 2 Lambeth Hill EC4V 4GG London 5th Floor Millennium Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 209094790001 | |||||||||
| CARTER, Kevin James, Dr | Administrateur | Brantwood 23 Fairway Merrow GU1 2XL Guildford Surrey | British | 10570530006 | ||||||||||
| CLARK, Stephen | Administrateur | The Grey House Langton Road Langton Green TN3 0HP Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 52747390002 | |||||||||
| COXON, Robert Harold | Administrateur | 2 Lambeth Hill EC4V 4GG London 5th Floor Millennium Bridge House United Kingdom | United Kingdom | Australian | 65171530001 | |||||||||
| CUTHBERTSON, Boyd | Administrateur | 6 Hillbury Gardens CR6 9TQ Warlingham Surrey | England | British | 70216910001 | |||||||||
| DAVIES, Mark Edward Trehearne | Administrateur | 26 Chester Street SW1X 7BL London | England | British | 82536300001 | |||||||||
| DUGDALE, David John | Administrateur | Icomb Bank Icomb GL54 1JD Cheltenham Gloucestershire | British | 98118020001 | ||||||||||
| ELKINGTON, Robert John | Administrateur | Cranbourne Grange Sutton Scotney SO21 3NA Winchester Hampshire | British | 3175220001 | ||||||||||
| FRIEDLOS, Stephen Michael | Administrateur | Clifford House Christmas Hill GU4 8HP Guildford Surrey | England | British | 82802310001 | |||||||||
| GORDON, Thomas John Robert | Administrateur | Spring Farm Stratford St Mary CO7 6NB Colchester Essex | British | 9903520001 | ||||||||||
| GRIFFIN, Garth | Administrateur | Klaasenbosch Cottage 78 Brommersvlei Road FOREIGN Constantia 7800 South Africa | South African | 47068990001 | ||||||||||
| HEAD, Robert Michael | Administrateur | 33 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | 10962510002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur QUILTER PERIMETER LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilter Perimeter Holdings Limited | 24 nov. 2017 | 85 Queen Victoria Street EC4V 4AB London Senator House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Om Group (Uk) Limited | 06 avr. 2016 | 2 Lambeth Hill EC4V 4GG London 5th Floor Millennium Bridge House | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0