PANTHERIX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPANTHERIX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03464985
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PANTHERIX LIMITED ?

    • Autres activités de recherche-développement en sciences naturelles et en ingénierie (72190) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PANTHERIX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o JOHNSTON CARMICHAEL
    107-111 Fleet Street
    EC4A 2AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PANTHERIX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AZTECEQUAL LIMITED13 nov. 199713 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de PANTHERIX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour PANTHERIX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 déc. 2016

    7 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Excalibur Fund Managers Ltd Berkeley Square House Berkeley Square Mayfair London W15 6BD à C/O Johnston Carmichael 107-111 Fleet Street London EC4A 2AB le 11 janv. 2016

    3 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    4 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 22 déc. 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2014

    État du capital au 17 déc. 2014

    • Capital: GBP 41,822.24
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014

    11 pagesAA

    Nomination de Farhad Fred Fahid en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    10 juin 2020Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 10/06/2020 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 nov. 2013

    État du capital au 26 nov. 2013

    • Capital: GBP 41,822.237
    SH01

    Cessation de la nomination de Mark Docherty en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark James Docherty le 07 févr. 2013

    3 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 nov. 2012

    14 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2011

    11 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 nov. 2010

    14 pagesAR01

    Nomination de Alexander Morrison Mcdougall en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Alexander Morrison Mcdougall en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de John Gonzalez-Carvajal en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de PANTHERIX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Hazelden Road
    Mearnskiry
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    British156743750001
    FAHID, Farhad
    W8
    Administrateur
    W8
    EnglandBritish186461120001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    Administrateur
    c/o Johnston Carmichael
    Fleet Street
    EC4A 2AB London
    107-111
    United KingdomBritish67155220007
    DOCHERTY, Mark James
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 The Lye
    Little Gaddesden
    HP4 1UH Berkhamsted
    Hertfordshire
    British47388290002
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    WHITROW, Jane Elizabeth, Dr
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    40 Gun Lane
    SG3 6BH Knebworth
    Hertfordshire
    British78788220001
    ATLANTIC CORRIE LTD (SC280885)
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Hazelden Road
    Mearnskirk
    G77 6RR Glasgow
    Duisdale
    Renfrewshire
    107928480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENEDICT, Nicholas Matthew
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    Administrateur
    Spalentorheg 31
    Basel 4051
    Switzerland
    British131280480001
    CLARK, Alan Stuart
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    Administrateur
    Kings Barn
    Bentworth
    GU34 5JU Alton
    Hampshire
    British67234920002
    COOPER, Robin David Grey
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    Administrateur
    6740 Dover Road
    FOREIGN Indianapolis
    Indiana 46220
    Usa
    British-Us77211370001
    D'ORSA, Salvatore
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Administrateur
    33 King Stret
    SW1Y 6RJ London
    Italian95545080003
    DOCHERTY, Mark James
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    Administrateur
    c/o Avlar Bioventures Ltd
    Church Lane
    CB23 8AG Madingley
    Highfield Court
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritish47388290006
    FREEMAN, George William
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    Administrateur
    13 Warwick Square
    SW1V 2AB London
    British70152070002
    GENNERY, Brian Albert, Dr
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    6 Qualitas
    RG12 7QG Bracknell
    Berkshire
    United KingdomBritish89422310001
    GONZALEZ-CARVAJAL, John Ramon, Dr
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    Administrateur
    Piazzale F Baracca 1
    20123 Milano
    Italy
    British74227120004
    GREENE, Andrew Fay
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    Administrateur
    18 Caithness Road
    W14 0JA London
    EnglandAmerican86855850001
    HOLT, Elizabeth
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    Administrateur
    East Garnet House
    Caup Road
    SW19 4UW London
    British73547900001
    KEEN, Peter Stephen
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    26 Manor Road
    Hemingford Grey
    PE28 9BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish38560002
    LATHAM, Christopher John, Dr
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    Administrateur
    6 North Gardner Street
    G11 5BT Glasgow
    British78599550002
    MACDONALD, Cameron Mackay
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    Administrateur
    10 Paxton Close
    MK46 5PR Olney
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56171470001
    MCDOUGALL, Alexander Morrison
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    Administrateur
    Greenside Farm Cottage
    Barnaigh Road
    PA10 2PE Kilbarchan
    Renfrewshire
    British67155220005
    POWELL, Kenneth Leslie, Professor
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    Administrateur
    Wheatfields Hill Boxes Farm
    Marden Park Woldingham
    CR3 7JD Caterham
    Surrey
    British50259160001
    SHAW, William Vare, Professor
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Lanarkshire
    American57716570002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    PANTHERIX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture creating a floating charge
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 19 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Biosciences Fund L.P. Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited,Merlin Biosciences Fund Gbr, Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transactions
    • 19 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Créé le 27 févr. 2004
    Livré le 19 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    And any goodwill and any unpaid share capital. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Biosciences Fund L.P. and Merlin Biosciences Fund Gbr and Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transactions
    • 19 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture creating a floating charge
    Créé le 10 oct. 2003
    Livré le 22 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transactions
    • 22 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Amended and restated convertible secured promissory note
    Créé le 08 oct. 2003
    Livré le 20 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    $2,500,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gpc Biotech Ag
    Transactions
    • 20 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever, both present and future, including, without limitation, any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Biosciences Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited Andmerlin Biosciences Fund Gbr Acting by Its Managing Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 avr. 2003
    Livré le 22 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £250,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All of the proerty assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Bioscience Fund LP, Merlin Biosciences Fund Gbr & Mb Venture Capital Fund 1 Nv
    Transactions
    • 22 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Convertible secured promissory note
    Créé le 22 août 2002
    Livré le 03 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us $2,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's right, title and interest in and to any and all intellectual property rights that are conceived, discovered, identified or first reduced to practice by the company's exercise or certain of the company's rights under the licence agreement.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gpc Biotech Ag
    Transactions
    • 03 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture creating a floating charge
    Créé le 05 juin 2002
    Livré le 25 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Merlin Bioscience Fund LP Acting by Its General Partner Merlin General Partner Ii Limited
    Transactions
    • 25 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 11 janv. 2000
    Livré le 31 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future liabilities of the company to the chargee under pursuant to or in connection with the facility letter dated 11TH january 2000 (together with any letter, deed, documents or other agreement present or future confirming, varying, amending or supplementing such letter) and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the charge
    Brèves mentions
    All of the property, assets and undertaking of the company whatsoever both present and future including without limitation any goodwill and any unpaid share capital of the company.
    Personnes ayant droit
    • Merlin General Partner Limited
    Transactions
    • 31 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PANTHERIX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 déc. 2015Commencement of winding up
    12 avr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Purdon Henderson
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    practitioner
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0