NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS

NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 03465914
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    • Enseignement supérieur de troisième cycle (85422) / Enseignement

    Où se situe NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Adresse du siège social
    Dc. 115 The Clarence Centre
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE COUNCIL FOR INDUSTRY AND HIGHER EDUCATION14 nov. 199714 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 oct. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation12 nov. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 oct. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Judith Irene Petts en tant que directeur le 01 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    33 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    32 pagesAA

    Statuts

    19 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    7 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Nomination de Sir John Manzoni Kcb en tant qu'administrateur le 08 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    34 pagesAA

    Nomination de Sir Jonathan Richard Symonds en tant qu'administrateur le 08 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Professor Judith Irene Petts en tant qu'administrateur le 08 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Professor Ian Hugh White en tant qu'administrateur le 08 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Professor Trevor John Mcmillan en tant qu'administrateur le 08 déc. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Andrew Phoenix en tant que directeur le 08 déc. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed the council for industry and higher education\certificate issued on 11/10/22
    4 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement de nom" avec demande d'observations de l'organisme compétent

    2 pagesNM06

    Exemption de changement de nom" de l'utilisation de "limitée" ou "cyfyngedig"

    1 pagesNE01

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Nomination de Mrs Adele Leana Every en tant qu'administrateur le 05 oct. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Scott Meads en tant que directeur le 16 mars 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    35 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 oct. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Julie Elspeth Lydon en tant que directeur le 31 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARSHALL, John Joseph, Dr
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Secrétaire
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    180610950001
    BROWN, David Watson Mcnair
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    ScotlandBritishUniversity Director262049380001
    EVERY, Adele Leana
    New Square
    Cisco Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9-11
    England
    Administrateur
    New Square
    Cisco Bedfont Lakes
    TW14 8HA Feltham
    9-11
    England
    EnglandBritishManaging Director, Public Sector, Cisco266288220001
    EZINGEARD, Jean-Noël Christian Francois, Professor
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritish,FrenchVice-Chancellor258337110001
    LAIDLAW, William Samuel Hugh
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishDirector199647550001
    MANZONI KCB, John, Sir
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishCivil Servant304653910001
    MCMILLAN, Trevor John, Professor
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishVice-Chancellor44237610003
    RABONE, Robert
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishChartered Accountant113482740001
    SANDBACH, David Roy
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    United KingdomBritishProfessor254783420001
    SYMONDS, Jonathan Richard
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    United KingdomBritishChairman194340720001
    WHITE, Ian Hugh, Professor
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishVice-Chancellor303105780001
    BLAKE, Barbara Margaret
    67 Vanbrugh Hill
    Greenwich
    SE10 9HB London
    Secrétaire
    67 Vanbrugh Hill
    Greenwich
    SE10 9HB London
    British55554800001
    DOCHERTY, David, Doctor
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Secrétaire
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    164212560001
    HERRMANN, Keith
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Secrétaire
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    British123669810003
    ATKINS, Madeleine Julia, Professor
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Administrateur
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    EnglandBritishProfessor101177320001
    BEER, Janet Patricia, Professor
    Gipsy Lane
    OX3 0BP Oxford
    Oxford Brooks University
    Oxfordshire
    England
    Administrateur
    Gipsy Lane
    OX3 0BP Oxford
    Oxford Brooks University
    Oxfordshire
    England
    EnglandBritishVice Chancellor125258750001
    BICHARD, Michael George, Lord
    Dudley House
    West Moreland Street
    W1G 8PN London
    15
    Administrateur
    Dudley House
    West Moreland Street
    W1G 8PN London
    15
    United KingdomBritishUniversity Rector129682770001
    BONE, Roger Bridgland, Sir
    Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    5
    England
    Administrateur
    Roxburghe Mansions
    32 Kensington Court
    W8 5BQ London
    5
    England
    United KingdomBritishBusinessman Retired106476290001
    BUCKINGHAM, Julia Clare, Professor Dame
    Kingston Lane
    UB8 3PH Uxbridge
    Brunel University London
    Middlesex
    England
    Administrateur
    Kingston Lane
    UB8 3PH Uxbridge
    Brunel University London
    Middlesex
    England
    EnglandBritishVice Chancellor22071560001
    BURNETT, Keith, Professor Sir
    Snaithing Lane
    S10 3LF Sheffield
    The Croft
    England
    Administrateur
    Snaithing Lane
    S10 3LF Sheffield
    The Croft
    England
    United KingdomBritishVice-Chancellor125056060001
    CASSELS, John Seton, Sir
    10 Beverley Road
    Barnes
    SW13 0LX London
    Administrateur
    10 Beverley Road
    Barnes
    SW13 0LX London
    BritishPublic Servant (Ret.)1788970001
    COPLAND, Geoffrey Malcolm, Dr
    24 The Broadway
    Gustard Wood Wheathampstead
    AL4 8LN St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    24 The Broadway
    Gustard Wood Wheathampstead
    AL4 8LN St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishVice Chancellor58777170001
    FALLON, Marianne
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Administrateur
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    EnglandBritishChartered Accountant193865200001
    GARDNER, Scot Matthew
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    Administrateur
    6 St. Georges Circus
    SE1 6FE London
    Dc. 115 The Clarence Centre
    England
    EnglandBritishChief Executive234517110001
    GIPPS, Caroline Victoria, Professor
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Administrateur
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    United KingdomBritishVice Chancellor108623920001
    GREENHALGH, Richard Cecil
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Administrateur
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    United KingdomBritishCompany Chairman59863820001
    HERON, Michael Gilbert, Sir
    43 Albion Gate
    Albion Street
    W2 2LG London
    Administrateur
    43 Albion Gate
    Albion Street
    W2 2LG London
    BritishCompany Chairman (Retired)45699290003
    JOHN, David Glyndwr, Sir
    12 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    Administrateur
    12 Grosvenor Crescent Mews
    SW1X 7EU London
    United KingdomBritishCompany Chairman10816600003
    KING, Julia Elizabeth, Professor Dame
    Aston Triangle
    B4 7ET Birmingham
    Aston University
    England
    Administrateur
    Aston Triangle
    B4 7ET Birmingham
    Aston University
    England
    EnglandBritishVice-Chancellor85621360001
    LAMBERT, Richard Peter, Sir
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    Administrateur
    Studio 11 Tiger House
    Burton Street
    WC1H 9BY London
    EnglandBritishBusiness Advisor9970270001
    LYDON, Julie Elspeth, Professor Dame
    Llantwit Road
    CF37 1DL Pontypridd
    Ty Crawshay
    Mid Glamorgan
    Wales
    Administrateur
    Llantwit Road
    CF37 1DL Pontypridd
    Ty Crawshay
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishVice-Chancellor152161710001
    MARGETTS, Robert John, Sir
    C/O Matlin Patterson
    7th Floor Buchanan House
    SW1Y 4JU 3 St James's Square London
    Administrateur
    C/O Matlin Patterson
    7th Floor Buchanan House
    SW1Y 4JU 3 St James's Square London
    EnglandBritishEngineer11862560006
    MCDONAGH, Francesca Jane
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Hsbc, Level 26
    England
    Administrateur
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Hsbc, Level 26
    England
    UkBritishBanker203170940001
    MCKILLOP, Thomas Fulton Wilson, Sir
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    Administrateur
    36 St Andrew Square
    EH2 2YB Edinburgh
    United KingdomBritishChairman61993170004
    MEADS, David Scott
    New Square
    TW14 8HA Feltham
    Cisco, Building 10
    England
    Administrateur
    New Square
    TW14 8HA Feltham
    Cisco, Building 10
    England
    EnglandBritishVice President, Cisco Uk & Ireland141268260001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour NATIONAL CENTRE FOR UNIVERSITIES AND BUSINESS ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    29 oct. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0