LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED

LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLG/SL (H INVESTMENT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03468246
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    • (7012) /
    • (7487) /

    Où se situe LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Cabot Square
    London
    E14 4QJ
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOVEREIGN LAND (H INVESTMENT) LIMITED09 mars 200009 mars 2000
    LIONSGATE (H) INVESTMENT LIMITED09 janv. 199809 janv. 1998
    FINISHPOOL LIMITED19 nov. 199719 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2010

    État du capital au 19 nov. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Susannah Louise Aliker en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Reid en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Studd en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Paul Edward Hare en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kevin Lester Studd le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Costas Michaelides le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Paul Edward Hare le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew William Reid le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    British23220350004
    ALIKER, Susannah Louise
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    1
    United KingdomBritishAccountant99766410001
    HARE, Paul Edward
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United KingdomBritishCompany Secretary23220350004
    MICHAELIDES, Costas, Chair Of The Board Of Directors
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomAmerican,CypriotCompany Director73091230001
    HORNSEY, Nicholas John
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    Secrétaire
    Eremue
    8 The Avenue
    TW12 3RS Hampton
    Middlesex
    BritishSolicitor50650950002
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    BritishAccountant50173270002
    WATKINS, Andrew
    9 Wexford Lodge 163 Nightingale Lane
    SW12 8NL London
    Secrétaire
    9 Wexford Lodge 163 Nightingale Lane
    SW12 8NL London
    British65933670001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secrétaire
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    AARONSON, Glenn Hunter
    Wild Strawberry House
    Love Lane
    GU31 4BU Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Wild Strawberry House
    Love Lane
    GU31 4BU Petersfield
    Hampshire
    AmericanInvestment Banker61193890002
    ADAM, Marc Josef
    Whins The Drive
    Wonersh
    GU5 0QW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Whins The Drive
    Wonersh
    GU5 0QW Guildford
    Surrey
    CanadianInvestment Banker80048740001
    BINNINGTON, Timothy John
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Thakeham Place
    Thakeham
    RH20 3EP Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritishChartered Surveyor4831260001
    BRETTON, Nigel Paul
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Blue Clay
    33 Rose Walk
    AL4 9AA St Albans
    Hertfordshire
    BritishFinancial Controller75188550001
    BURROWES, Kevin James
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Samuelson House
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LP Cobham
    Surrey
    BritishEuropean Financial Controller105411790001
    FALLS, Robert Richard William
    4 Virginia Place
    Between Streets
    KT11 1AE Cobham
    Surrey
    Administrateur
    4 Virginia Place
    Between Streets
    KT11 1AE Cobham
    Surrey
    BritishCompany Director16501250006
    IVES, Stephen Edward
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Cottars
    St Leonards Hill
    SL4 4AL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant50173270002
    MCMILLAN, Gillian Patricia
    16 Orford Road
    South Woodford
    E18 1PY London
    Administrateur
    16 Orford Road
    South Woodford
    E18 1PY London
    EnglandBritishAccountant109683100002
    NASH, Jeffrey Frederick
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    Administrateur
    The Coach House St Matthews Road
    Ealing
    W5 3JT London
    United KingdomBritishBanker53992520001
    NEWMAN, Graeme Phillip
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Magpies Lynx Hill
    East Horsley
    KT24 5AX Leatherhead
    Surrey
    BritishSurveyor4831270001
    PATRICK, Christopher John
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    Administrateur
    12 Fitzroy Crescent
    Chiswick Place
    W4 3EL London
    UsaBanker48804210001
    PATTINSON, Michael John
    10 Sandgate Lane
    Wandsworth Common
    SW18 3JP London
    Administrateur
    10 Sandgate Lane
    Wandsworth Common
    SW18 3JP London
    BritishSolicitor55991430001
    REID, Andrew William
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker126957830001
    SCHWARTZ, Jeffrey Leonard
    Flat 22
    19 Princes Street
    W1B 2LW London
    Administrateur
    Flat 22
    19 Princes Street
    W1B 2LW London
    AmericanInvestment Banker69783860002
    STUDD, Kevin Lester
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    Administrateur
    Cabot Square
    E14 4QJ London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor86302520001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    LG/SL (H INVESTMENT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture
    Créé le 21 janv. 1999
    Livré le 22 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    3 & 4 queen square high wycombe lancashire t/no: BM4010 f/h property k/a chilterns shopping centre frogmore high wycombe t/nos: BM87997 and BM209703 l/h property k/a unit 7 the chilterns shopping centre frogmore high wycombe t/no: BM113100. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellchaft, London Branch
    Transactions
    • 22 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 21 déc. 1998
    Livré le 31 déc. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or lionsgate properties limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Various properties briefly described as the hersham green shopping centre, the chilterns shopping centre high wycombe, 1/2 & 3/4 queen square high wycombe, the park farm centre birchover way and land to the south of birchover way derby, l/h manchester international office centre & l/h anchorage park portsmouth and all buildings fixtures plant and machinery, benefits of insurances, licences. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse First Boston
    Transactions
    • 31 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 sept. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 27 févr. 1998
    Livré le 19 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a farringdon place, rossendale road industrial estate, burnley lancashire; f/h property k/a 115/127 (odd) and exchange mansions golders green road golders green london; f/h property k/a deacon trading estate dominion way, worthing t/nos: LA628087 ngl 432387 WSX186809 and WSX186810 .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bayerische Hypotheken- Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft,London Branch
    Transactions
    • 19 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0