TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED

TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03468484
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LIFESTYLE HOUSEHOLD UNDERWRITING AGENCY LIMITED19 nov. 199719 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Towergate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN à 92 London Street Reading Berkshire RG1 4SJ le 23 juin 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 nov. 2014

    État du capital au 21 nov. 2014

    • Capital: GBP 95
    SH01

    Cessation de la nomination de Mark Steven Hodges en tant que directeur le 17 oct. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Nomination de Jennifer Owens en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 nov. 2013

    État du capital au 22 nov. 2013

    • Capital: GBP 95
    SH01

    Cessation de la nomination de Samuel Clark en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Peter Cullum en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Mark Steven Hodges en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Philip en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Scott Egan en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Hunter en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Samuel Thomas Budgen Clark en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Stewart Hunter en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Darryl Clark en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OWENS, Jennifer
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Secrétaire
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    183297080001
    EGAN, Scott
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Administrateur
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish170703910001
    ALEXANDER, Peter
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    Secrétaire
    4 Pintail Way
    Broomfield
    CT6 7XP Herne Bay
    Kent
    British60245740001
    CLARK, Darryl
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secrétaire
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    153032640001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secrétaire
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    161873210001
    CRATON, Timothy Charles
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Secrétaire
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    British76055420004
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Secrétaire
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    British99424380001
    HUNTER, Andrew Stewart
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Secrétaire
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    156608080001
    REDDI, John
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    Farbank 21 First Avenue
    BN14 9NJ Worthing
    West Sussex
    British6180280001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CROCKER, Nicholas John David
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    Administrateur
    The Barn
    Little Biddenden Green Lewd Lane
    TN27 8NP Smarden
    Kent
    British60697560014
    CROWTHER, Roger
    167 Arnold Avenue
    Gleadless
    S12 3JD Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    167 Arnold Avenue
    Gleadless
    S12 3JD Sheffield
    South Yorkshire
    British42039250001
    CULLUM, Peter Geoffrey
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    EnglandBritish59873490009
    DYER, Paul Francis
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    Administrateur
    The Foxes
    Eastling Road Ospringe
    ME13 0RT Faversham
    Kent
    EnglandBritish99424380001
    HODGES, Mark Steven
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    Administrateur
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    United KingdomBritish58444370003
    PHILIP, Timothy Duncan
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    Administrateur
    Eclipse Park, Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    Kent
    England
    United KingdomBritish99066410001
    PROVERBS, Antony
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    Administrateur
    27 Capital Wharf
    50 Wapping High Street
    E1W 1LY London
    EnglandBritish79185700012
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 août 2001
    Livré le 13 sept. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (the agent), the lender, the mezzanine lender, the overdraft bank, the hedging bank, the zero per cent lenders, the investors and to any of them on any account whatsoever including without limitation under any of the financing documents (all terms as defined)
    Brèves mentions
    (Other than f/h property k/a 317 woodham lane new haw t/no.SY350608 and the f/h land at the south west of scotland bridge road new haw t/no.SY536467 in each case so long as the same is charged by towergate chase parkinson limited to coutts & co). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 sept. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of legal charge
    Créé le 15 mai 2001
    Livré le 23 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any of the other companies named therein ("the chargors") to the chargee pursuant to the framework agreement or the charge
    Brèves mentions
    The assigned rights being all the rights, titles, benefits and interests of the company to the commissions. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Insurance Limited
    Transactions
    • 23 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 07 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender, the Mezzanine Lender, the Overdraft Bank, the Hedging Bank and the Investor (All as Defined)
    Transactions
    • 07 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 18 déc. 1998
    Livré le 06 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Mezzanine Limited,as Agent and Trustee for Itself and for Each of the Lender,the Overdraftbank,the Hedging Bank and the Investors (All Asdefined)
    Transactions
    • 06 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    TOWERGATELIFESTYLE UNDERWRITING LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juin 2015Commencement of winding up
    28 janv. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David William Tann
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    practitioner
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    practitioner
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0