PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED

PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03470856
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ELBA INVESTMENTS PLC15 déc. 199715 déc. 1997
    WELLINGTON FINANCE PLC19 nov. 199719 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le11 août 2022
    Date d'échéance des prochains comptes11 mai 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au29 nov. 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation13 déc. 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au29 nov. 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2025

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2024

    8 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2023

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    État du capital après une attribution d'actions au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 9,367,887
    3 pagesSH01

    État du capital au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled/reserve account credited to profit and loss account 09/03/2023
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Removal of directors and appointment of director 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    8 pagesMA

    Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 15 août 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 16 août 2020

    4 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 nov. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2018

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritish299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629720001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175490400001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Secrétaire
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161809430001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Administrateur
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    British46361590002
    MYERS, Roger
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    Administrateur
    Fern Lodge
    5 Millfield Lane Highgate
    N6 6JL London
    United KingdomBritish56413030004
    OSMOND, Hugh
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    Administrateur
    10 Wellington Road
    NW8 9SP London
    British6209210002
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SHURE, Randl Louis
    45 Addison Road
    W14 8JH London
    Administrateur
    45 Addison Road
    W14 8JH London
    Usa57895060001
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128819260001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3512367
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Second ranking fixed and floating security document
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 18 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 18 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 16 janv. 2006
    Livré le 23 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First legal mortgage all property in england and wales,first fixed euitable charge all other property,first fixed charge all its present and future book debts,bank accounts,investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transactions
    • 23 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge and priority
    Créé le 01 sept. 1999
    Livré le 21 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a guarantee of punch group limited's obligations under a deed poll constituting series a loan notes due 2009 to a maximum of £146,000,000
    Brèves mentions
    All real property,plant,machinery and equipment owned by the chargor and all investments,rights,goodwill of business and all uncalled capital; all book debts and bank balances and all other assets,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transactions
    • 21 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PUNCH TAVERNS INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2023Commencement of winding up
    21 mars 2023Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0