MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED

MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03471396
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AMBIENT ENERGY LIMITED12 déc. 199712 déc. 1997
    PLEDGEPOWER LIMITED26 nov. 199726 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Cessation de la nomination de David Huw Griffiths en tant que directeur le 02 mars 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 11 déc. 2020

    10 pagesLIQ03

    legacy

    pagesANNOTATION

    legacy

    pagesANNOTATION

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 16 st Martins Le Grand St Martins House London EC1A 4EN

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 16 st Martins Le Grand St Martins House London EC1A 4EN

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de C/O Morton Fraser 16 st. Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN England à 1 More London Place London SE1 2AF le 08 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 12 déc. 2019

    LRESSP

    Cessation de la nomination de David Mel Zuydam en tant que directeur le 01 janv. 2020

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr David Mel Zuydam en tant qu'administrateur le 11 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Katerina Brown en tant que directeur le 04 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Scott Leitch Mackenzie en tant que directeur le 30 janv. 2019

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 26 févr. 2019

    • Capital: GBP 0.721245
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 19/02/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Andrew William Lee en tant que directeur le 05 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Alan Walters en tant que directeur le 05 déc. 2018

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    15 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Secrétaire
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrementSC262093
    95512800001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Secrétaire
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    201246090001
    BISSET, Graham Ferguson
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    194566980001
    CALDER, Samantha Jane
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    Secrétaire
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    British75830790003
    HULLEY, Christine Wyn
    2 Felltop Drive
    Reddish Vale
    SK5 6YS Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    2 Felltop Drive
    Reddish Vale
    SK5 6YS Stockport
    Cheshire
    British35745290001
    KENNA, Jeffrey Paul, Dr
    Overmoor Farm
    Neston
    SN13 9TZ Corsham
    Wiltshire
    Secrétaire
    Overmoor Farm
    Neston
    SN13 9TZ Corsham
    Wiltshire
    BritishDirector2042580002
    LONG, Jacqueline
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    Secrétaire
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    204212660001
    MITCHELL, Christopher John
    53 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3DW Bristol
    Secrétaire
    53 Stoke Lane
    Westbury On Trym
    BS9 3DW Bristol
    British19750010001
    OLDROYD, Elizabeth Alexandra
    19 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GF Bath
    Secrétaire
    19 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GF Bath
    British98205520001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    Administrateur
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    EnglandBritishFinance Director294355310001
    BART, Stephen Leonard
    311 Lakeside Greens Court
    Chestermere
    Alberta T1x 1c8
    Canada
    Administrateur
    311 Lakeside Greens Court
    Chestermere
    Alberta T1x 1c8
    Canada
    CanadianDirector85735170001
    BOYD, Gordon Alexander
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer148856600001
    BROWN, John Ernest
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    10 Stonegate Fold
    Heath Charnock
    PR6 9DX Chorley
    Lancashire
    EnglandBritishCertified Accountant11806560001
    BROWN, Katerina
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    Administrateur
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    ScotlandBritishAccountant232165890001
    DAUCE, David Peter
    16 Abbotts Walk
    GL7 3DB Lechlade
    Gloucestershire
    Administrateur
    16 Abbotts Walk
    GL7 3DB Lechlade
    Gloucestershire
    BritishCommercial Director7304980001
    EDWARDS, Mark Simon
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    2 Brook House Court
    Lakeside Road
    WA13 0GR Lymm
    Cheshire
    BritishGm - Finance109659860001
    FITZSIMMONS, David Stephen
    Hammer Tower
    Penshurst
    TN11 8HZ Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Hammer Tower
    Penshurst
    TN11 8HZ Tonbridge
    Kent
    United KingdomBritishCeo109928450001
    GANNON, Shane Michael
    42 Riverside Drive
    Sandringham
    New South Wales 2219
    Australia
    Administrateur
    42 Riverside Drive
    Sandringham
    New South Wales 2219
    Australia
    AustralianDirector86673690001
    GANNON, Shane Michael
    42 Riverside Drive
    Sandringham
    New South Wales 2219
    Australia
    Administrateur
    42 Riverside Drive
    Sandringham
    New South Wales 2219
    Australia
    AustralianDirector86673690001
    GRIFFITHS, David Huw
    St Martins House
    16 St Martins Le Grand
    ECA1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    Administrateur
    St Martins House
    16 St Martins Le Grand
    ECA1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritishCoo177733400003
    HARDMAN, Steven Neville
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    United Kingdom
    UkBritishSolicitor93743250007
    HEWSON, John Francis
    30 Bedford Street
    London
    WC2E 9ED
    Administrateur
    30 Bedford Street
    London
    WC2E 9ED
    United KingdomBritishDevelopment Director120308140001
    HINTON, Thomas Edward
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Administrateur
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    EnglandBritishChief Finance Officer238940970001
    KAY, Ian Andrew
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    Administrateur
    17 Jenner Street
    Seaforth
    New South Wales 2092
    Australia
    BritishInvestment Banker102259090001
    KENNA, Jeffrey Paul, Dr
    Overmoor Farm
    Neston
    SN13 9TZ Corsham
    Wiltshire
    Administrateur
    Overmoor Farm
    Neston
    SN13 9TZ Corsham
    Wiltshire
    EnglandBritishEnergy2042580002
    LEE, Andrew William
    c/o Morton Fraser Llp
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    St Martins House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Morton Fraser Llp
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    St Martins House
    United Kingdom
    United KingdomBritishEnergy Finance Professional87527870001
    MACHIELS, Eric Philippe Marianne, Dr
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    Administrateur
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    United KingdomBelgiumDirector125748990001
    MACKENZIE, Scott Leitch
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    Administrateur
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    United KingdomBritishDirector277478140001
    MILLER, David Muir
    The Old Boat House Inn
    1 Warrington Lane
    WA13 0UH Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    The Old Boat House Inn
    1 Warrington Lane
    WA13 0UH Lymm
    Cheshire
    United KingdomBritishCeo69864850004
    NAGLE, Michael
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    Administrateur
    16 St. Martin's Le Grand
    St Martins House
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser
    England
    United KingdomBritishCompany Director29436380007
    QUINLAN, Rory John
    Flat 12 25 Queen's Gate Gardens
    South Kensington
    SW7 5RP London
    Administrateur
    Flat 12 25 Queen's Gate Gardens
    South Kensington
    SW7 5RP London
    AustralianCfo113941780001
    ROUND, Richard Calvin
    Elimbriar 8 Station Road
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    Beds
    Administrateur
    Elimbriar 8 Station Road
    Stanbridge
    LU7 9JF Leighton Buzzard
    Beds
    UkBritishFinance Director108158250002
    SCAYSBROOK, David Andrew
    7 Durrington Park Road
    Wimbledon
    SW20 8NU London
    Administrateur
    7 Durrington Park Road
    Wimbledon
    SW20 8NU London
    AustralianExecutive Chairman97490770001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Infinis Wind Holdings Limited
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    St Martins House
    England
    30 avr. 2017
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    St Martins House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleComapnies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement7086998
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 déc. 2017
    Livré le 29 déc. 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC, 4TH Floor, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom as Security Trustee (As Trustee for Each of the Secured Creditors)
    Transactions
    • 29 déc. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2013
    Livré le 11 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 déc. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 sept. 2012
    Livré le 21 sept. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 21 sept. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 14 janv. 2005
    Livré le 20 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 20 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 05 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from nm renewable energy (holdings 2) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • British Gas Trading Limited
    Transactions
    • 05 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2003
    Livré le 07 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank S.A./N.V.(As Agent and Security Trustess for Itself and Fortis Lease UK Limited)
    Transactions
    • 07 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    MYNYDD CLOGAU WINDFARM (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 févr. 2022Due to be dissolved on
    12 déc. 2019Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0