LIFE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIFE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03474139
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIFE LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe LIFE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIFE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PINCO 999 LIMITED01 déc. 199701 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de LIFE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 févr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour LIFE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Philip Hedley Bowcock en tant que directeur le 14 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Terence Douglas en tant qu'administrateur le 14 nov. 2011

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 août 2011

    État du capital au 16 août 2011

    • Capital: GBP 3,330,224
    SH01

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Philip Hedley Bowcock en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jayne Fearn en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Timothy O'gorman en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    23 pagesMG01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 févr. 2010

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Marks en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Luminar Leisure Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Comptes pour une société dormante établis au 26 févr. 2009

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    8 pages395

    legacy

    8 pages395

    legacy

    9 pages395

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages403a

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de LIFE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Secrétaire
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158741750001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Administrateur
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03802937
    152128400001
    FRIEND, Lynne
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Windborne House
    Ashbourne Road Turnditch
    DE56 2LH Derby
    Derbyshire
    British59349000001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secrétaire
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secrétaire
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    PORTER, Hugh Leslie
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    Secrétaire
    Hawthorn House
    Badger Road, Beckbury
    TF11 9DQ Shifnal
    Salop
    British63443690001
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    29 River Street
    SK9 4AB Wilmslow
    Cheshire
    British44233980001
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secrétaire
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    THORPE, Elizabeth Anne
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    85 Silverdale Road
    Earley
    RG6 7NF Reading
    Berkshire
    British63473530001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Secrétaire désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013300001
    ANDREW, Derek
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    Administrateur
    Church Hill House
    Church Hill, Kinver
    DY7 6HY Stourbridge
    West Midlands
    British66854930001
    BACON, Timothy Alan
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    Administrateur
    Chantry Cottage
    Brookhouse Green
    CW11 2XF Smallwood
    Cheshire
    EnglandBritish66652780001
    BARRATT, Simon Charles
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Longwood
    Langton Green
    TN3 0BA Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish14044440005
    BONNELL, William Andrew
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    Administrateur
    Ferry Lane Barn
    Ferry Road
    RG8 0JL South Stoke
    British101547740001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Administrateur
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BUCHAN, William James
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Winkworth Grange
    Hascombe Road South Munstead
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    EnglandBritish79917240001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Administrateur
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Administrateur
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    HINDS, John David
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    Administrateur
    The Granary
    Lower Wallington
    LL13 0AN Worthenbury
    Wrexham
    United KingdomBritish83825290003
    JONES, Mark Vincent
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 Lake View
    Moor Hall Lane St Michaels Head
    CM23 4GZ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British81765510001
    LIVINGSTONE, David Barry Hindle
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    Lakeside 20 Lakeside Road
    WA13 0QE Lymm
    Cheshire
    British142596910001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Administrateur
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Administrateur
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Administrateur
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    ROBERTS, Jeremy Kevin
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Wyndcroft
    Adlington Road
    SK9 2AL Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish44233980002
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    TAYLOR, Andrew Herbert Ian
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    Administrateur
    10 Aldwycks Close
    MK5 6HZ Milton Keynes
    United KingdomBritish116794160001
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Administrateur
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    Administrateur désigné
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    900013290001

    LIFE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 déc. 2010
    Livré le 15 déc. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of mortgage property please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtrues, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 déc. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Deed creating a floating charge
    Créé le 20 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 15 août 2007
    Livré le 30 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditors
    Transactions
    • 30 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge
    Créé le 16 déc. 2004
    Livré le 22 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transactions
    • 22 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 04 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge its undertaking and all assets present and future.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transactions
    • 04 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 30 janv. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 13 janv. 1999
    Livré le 25 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brèves mentions
    L/H licensed premises k/a 1A bold street liverpool and any proceeds of sale and all buildings and fixtures (including trade fixtures), the insurance policy taken out in respect of the property, the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transactions
    • 25 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 13 janv. 1999
    Livré le 19 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities now or hereafer due, owing or incurred by the company to the chargee under the terms of this chattel mortgage
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage: outside front - 10, stainless steel effect pedestal pavement cafe tables on pedestal supports with splayed feet. 34, stainless steel effect open arm pavement chairs with black woven seats and backs. Raised patio section - 4, ditto stainless steel pedestal tables.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 févr. 1998
    Livré le 10 mars 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marston Thompson & Evershed PLC
    Transactions
    • 10 mars 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 janv. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0