STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED

STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03477150
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HEADWORX (EUROPE) LIMITED05 déc. 199705 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Peter Grenville Rusby le 27 déc. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Grenville Rusby le 27 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2009

    État du capital au 27 nov. 2009

    • Capital: GBP 1,200,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    14 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2004

    18 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages88(2)R

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    1 pages123

    Comptes annuels établis au 31 mars 2003

    17 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Working capital facilit 16/12/03
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    legacy

    7 pages363s

    Qui sont les dirigeants de STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RUSBY, Peter Grenville
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    British16859340003
    BENTWOOD, Steven Michael
    Bankhall Corner
    110 Bankhall Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Bankhall Corner
    110 Bankhall Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish93615070002
    RUSBY, Peter Grenville
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    Administrateur
    Atlantic Street
    Broadheath
    WA14 5FY Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish16859340004
    WHITE, Angela Frances
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Secrétaire
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British48383080001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Secrétaire désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    GOWER, David Kevin
    Little Bown Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Administrateur
    Little Bown Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British37899800002
    SOLOMON, Peter Loris
    House 127, The Portofino
    88-188 Pak To Avenue Clearwater Bay
    Sai Kung New Territories
    Hong Kong
    Administrateur
    House 127, The Portofino
    88-188 Pak To Avenue Clearwater Bay
    Sai Kung New Territories
    Hong Kong
    Australian111531540004
    WHITE, Angela Frances
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    Administrateur
    Little Bourne Shewte Cross
    TQ13 9LQ Bovey Tracey
    Devon
    British48383080001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Administrateur désigné
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    STIRLING BRANDS INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2001
    Livré le 14 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 juin 2001
    Livré le 04 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement or otherwise
    Brèves mentions
    (I) by way of fixed charge any present or future debt the ownership of which fail to vest absolutely and effectively in the security holder for any reason together with the related rights (the factored debts) and (ii) all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever other than the factored debts (the other debts).by way of floating charge all the undertaking and all the property rights and assets.
    Personnes ayant droit
    • Bibby Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 juil. 2000
    Livré le 31 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 04 août 1999
    Livré le 06 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all debts purchased with all associated rights thereon.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Credit Services Limited
    Transactions
    • 06 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0