VENTUS INVESTMENTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | VENTUS INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03478754 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2024 | 34 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew David Bonner le 30 nov. 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Matthew David Bonner en tant qu'administrateur le 18 sept. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Marinus Maria Vermeer en tant que directeur le 18 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Florian Tobias Kron en tant que directeur le 26 août 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Christopher Neil Sharwood en tant qu'administrateur le 26 août 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 29 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 29 pages | MA | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 18 Riversway Business Village Navigation Way Preston PR2 2YP | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 18 Riversway Business Village Navigation Way Ashton-on-Ribble Preston PR2 2YP United Kingdom à 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate Street London EC1A 4HD le 05 avr. 2025 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Marinus Maria Vermeer en tant qu'administrateur le 18 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Omar Abbas Rahman en tant que directeur le 18 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Florian Tobias Kron en tant qu'administrateur le 18 mars 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alexander Michael Balikhin en tant que directeur le 18 mars 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Notification de Equitix Capital Eurobond 7 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mars 2025 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Rbs Investment Executive Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mars 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Natwest Pension Trustee Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mars 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 déc. 2023 | 35 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Omar Abbas Rahman le 11 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alexander Michael Balikhin le 11 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Alexander Michael Balikhin le 06 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Omar Abbas Rahman le 06 juin 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Omar Abbas Rahman le 20 mai 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARIO RENEWABLES LIMITED | Secrétaire | Riversway Business Village Navigation Way PR2 2YP Ashton-On-Ribble 18 Preston United Kingdom |
| 240766620001 | ||||||||||
| BONNER, Matthew David | Administrateur | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building, United Kingdom | United Kingdom | British | 339485420001 | |||||||||
| SHARWOOD, Christopher Neil, Mr. | Administrateur | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | England | Irish | 339510200001 | |||||||||
| BERESFORD, Robyn Fay | Secrétaire | West Bryson Road EH11 1BN Edinburgh 21/5 | Other | 132316300001 | ||||||||||
| CASTRO, Marcos | Secrétaire | 2b St Johns Road RH1 6HF Redhill Surrey | Other | 109248350003 | ||||||||||
| HOFMANN, David John | Secrétaire | 16 Sheredes Drive EN11 8LJ Hoddesdon Hertfordshire | British | 49331410001 | ||||||||||
| LEA, John Albert | Secrétaire | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | 1369400003 | ||||||||||
| RUSSELL, Christine Anne | Secrétaire | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 163984550001 | |||||||||||
| SMITH, Carolyn | Secrétaire | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | 68031820001 | ||||||||||
| WALLACE, Barbara Charlotte | Secrétaire | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 149200390001 | |||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Secrétaire | 6 Whitewood Cottages Whitewood Lane RH9 8JR South Godstone Surrey | Other | 67499700003 | ||||||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||
| PARIO LIMITED | Secrétaire | Hunting Gate SG4 0TJ Hitchin 2 Hertfordshire |
| 149862840001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| BALIKHIN, Alexander Michael | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HQ London 18th Floor, Tower 42, 25 England | United Kingdom | British | 283833070001 | |||||||||
| COLEMAN, Nicholas Charles | Administrateur | Ashdown House East Tanyard Lane RH17 7JW Danehill East Sussex | England | British | 191831630001 | |||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Administrateur | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| ENDERBY, William Kenneth | Administrateur | Thomas Wood Bank Lane Hildenborough TN11 8NR Kent | United Kingdom | British | 142990400001 | |||||||||
| HARROD, Nicholas Charles | Administrateur | 17 Bulrush Close ME5 9BN Chatham Kent | British | 56181640001 | ||||||||||
| HOFMANN, David John | Administrateur | 16 Sheredes Drive EN11 8LJ Hoddesdon Hertfordshire | British | 49331410001 | ||||||||||
| HOLMES, Richard John Russell | Administrateur | Holmewood Newick Lane TN20 6RB Mayfield East Sussex | British | 56181660001 | ||||||||||
| HOPKINS, Richard James | Administrateur | Flat 4 Kings View Court 115 Ridgway Wimbledon SW19 4RW London | England | British | 92378040002 | |||||||||
| JACKSON, James Anthony | Administrateur | Bishopsgate EC2M 4RB London, 280 England | England | British | 154943750001 | |||||||||
| KIRILOVA, Margarita | Administrateur | St. Mary Axe EC3A 8FR London 2nd Level, 50 England | United Kingdom | British | 306284230001 | |||||||||
| KRON, Florian Tobias | Administrateur | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | Germany | German | 330501830001 | |||||||||
| LE GAL, Anne-Noelle Noelle | Administrateur | St. Mary Axe EC3A 8FR London 50 England | England | French | 195454610001 | |||||||||
| LEA, John Albert | Administrateur | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | 1369400003 | ||||||||||
| MACARTHUR, Neil Clark | Administrateur | Rbs Gogarburn EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | United Kingdom | British | 81529340002 | |||||||||
| MORIARTY, Antoinette Una | Administrateur | 555 Rayners Lane HA5 5HP Pinner Middlesex | British | 54206370002 | ||||||||||
| NICHOLSON, Andrew James | Administrateur | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | Scotland | British | 163664680002 | |||||||||
| RAHMAN, Omar Abbas | Administrateur | Old Broad Street EC2N 1HQ London 18th Floor, Tower 42, 25 England | United Kingdom | Dutch | 308057600001 | |||||||||
| ROSATI, Valeria, Ms | Administrateur | St. Mary Axe EC3A 8FR London 2nd Level, 50 England | United Kingdom | Italian | 88030700002 | |||||||||
| SCHUBERT, Oliver Jan | Administrateur | St Mary Axe EC3A 8FR London 50 United Kingdom | United Kingdom | Austrian | 200913170001 | |||||||||
| SMITH, Carolyn | Administrateur | 9 Bedford Court Mowbray Road Upper Norwood SE19 2RW London | British | 68031820001 | ||||||||||
| STEWART, Gary Robert Mcneilly | Administrateur | Burnbrae Avenue EH12 8AU Edinburgh 10 Scotland | Scotland | British | 128173150002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VENTUS INVESTMENTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equitix Capital Eurobond 7 Limited | 18 mars 2025 | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Rbs Investment Executive Limited | 06 avr. 2016 | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh 175 Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Natwest Pension Trustee Limited | 06 avr. 2016 | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0