ROMARK ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéROMARK ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03482380
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ROMARK ESTATES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe ROMARK ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ROMARK ESTATES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ROMARK ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de The Coach House Thames Street Wallingford Oxfordshire OX10 0BH à C/O Critchleys Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street Oxford OX1 2EP le 21 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2018

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 034823800010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2018

    8 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2016 avec mises à jour

    7 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2016

    6 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    21 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2016

    État du capital au 22 janv. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2015

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ROMARK ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TYRRELL, Jenny Anne
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    British55734910001
    TYRRELL, Barry Clive
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Coach House Thames Street
    OX10 0BH Wallingford
    Oxfordshire
    EnglandBritish55734870002
    ASHBURTON REGISTRARS LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Secrétaire désigné
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014760001
    AR NOMINEES LIMITED
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    Administrateur désigné
    12-14 St Marys Street
    TF10 7AB Newport
    Shropshire
    900014750001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROMARK ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Barry Clive Tyrrell
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    06 avr. 2016
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des actions de la société.
    Mrs Jenny Anne Tyrrell
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    06 avr. 2016
    Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    C/O Critchleys
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    ROMARK ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 oct. 2014
    Livré le 14 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Grange farm shipton lee quainton bucks t/no.BM369695.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 27 nov. 2009
    Livré le 17 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Blankstones farm 39 acre end street eynsham witney oxfordshire t/no ON127861 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 12 oct. 2009
    Livré le 16 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 02 nov. 2005
    Livré le 03 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land with the buildings thereon k/a church farm barns, aldworth road, compton, newbury, berkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge of deposit
    Créé le 05 sept. 2005
    Livré le 10 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 66519969 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 juil. 2005
    Livré le 20 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property - the manor house, 2-3 high street, highworth, swindon t/no WT219121. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    17 brigham road reading berkshire fixed charge over all rental income and the proceeds of sale of any lease of the property. Floating charge over the undertaking all property assets and rights of the company.
    Personnes ayant droit
    • Capital Home Loans Limited
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 23 mai 2000
    Livré le 31 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property known as sandford park hotel 81/83 bath road cheltenham gloucestershire; t/no GR226703. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 23 mai 2000
    Livré le 30 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as eton lodge the park cheltenham gloucestershire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 30 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 02 févr. 1999
    Livré le 10 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a stanhope house 15 queens road cheltenham gloucestershire t/n GR210805. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    ROMARK ESTATES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 déc. 2018Commencement of winding up
    23 janv. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Milan Vuceljic
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Beaver House 23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    Lawrence John King
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire
    practitioner
    Critchleys Beaver House
    23-38 Hythe Bridge Street
    OX1 2EP Oxford
    Oxfordshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0