TI MAGAZINES (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TI MAGAZINES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03483202 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6th Floor 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 03 mars 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 02 mars 2020
| 3 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 20 févr. 2018
| 8 pages | SH01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England à 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR le 20 août 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 18 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Lauren Ezrol Klein en tant que secrétaire le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Marcus Alvin Rich en tant que directeur le 13 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Stephen John May en tant que directeur le 13 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Joseph Henry Ceryanec en tant qu'administrateur le 15 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr John Stanley Zieser en tant qu'administrateur le 15 févr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Susana D'emic en tant que directeur le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des détails de Time Uk Publishing Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juin 2016 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||||||
Notification de Time Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERYANEC, Joseph Henry | Administrateur | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 243478830001 | |||||
| ZIESER, John Stanley | Administrateur | 60 Gracechurch Street EC3V 0HR London 6th Floor England | United States | American | 217687580001 | |||||
| ALEY, William Robert | Secrétaire | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| GORE, John Francis | Secrétaire | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
| KLEIN, Lauren Ezrol | Secrétaire | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
| LINDEN, Brian Andrew | Secrétaire | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | British | 36233000002 | ||||||
| MCCARTHY, Robert | Secrétaire | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
| REDPATH, John | Secrétaire | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
| WILLIAMS, Sally Jane | Secrétaire | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALEY, William Robert | Administrateur | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | 25440920002 | ||||||
| ATKINSON, Richard Gordon | Administrateur | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | 78644420001 | ||||||
| AUTON, Sylvia Jean | Administrateur | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 59045280002 | |||||
| AVERILL, Howard | Administrateur | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | 127283350001 | |||||
| BAILEY, Sylvia | Administrateur | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | 67232740001 | ||||||
| BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Administrateur | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | 181954550002 | |||||
| D'EMIC, Susana Alves | Administrateur | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | 265525580001 | |||||
| DAVISON, Guy Bryce | Administrateur | 128 Kensington Park Road W1 2EP London | British | 48717030002 | ||||||
| EVANS, Richard John | Administrateur | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | 77303490001 | |||||
| EVANS, Sylvia Kathleen | Administrateur | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | 70941240001 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Administrateur | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| LINDEN, Brian Andrew | Administrateur | 7 Westmoreland Road Barnes SW13 9RZ London | United Kingdom | British | 36233000002 | |||||
| MAIR, Denise Margaret | Administrateur | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | 99076200001 | |||||
| MATTHEW, Michael | Administrateur | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | 40092920001 | ||||||
| MAY, Stephen John | Administrateur | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | 173367920001 | |||||
| MEREDITH, Charles Lloyd | Administrateur | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | 189455000001 | |||||
| MUNTON, Richard James | Administrateur | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | 11882410003 | ||||||
| RICH, Marcus Alvin | Administrateur | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | 185688190001 | |||||
| ROSEN, Howard Norman | Administrateur | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | 111282190001 | |||||
| WEBSTER, Evelyn Ann | Administrateur | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | 68847920003 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Uk Publishing Holdings Limited | 04 juin 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Time Inc. | 06 avr. 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TI MAGAZINES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 13 août 1999 Livré le 02 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Créé le 12 oct. 1998 Livré le 15 oct. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 janv. 1998 Livré le 06 févr. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0