TI MAGAZINES (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTI MAGAZINES (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03483202
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    • Activités des autres sociétés holding n.c.a. (64209) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6th Floor 60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IPC MAGAZINES (UK) LIMITED03 févr. 199803 févr. 1998
    EXCESSTOP LIMITED18 déc. 199718 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 03 mars 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 02/03/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 02 mars 2020

    • Capital: GBP 30,140.6603
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 20 févr. 2018

    • Capital: GBP 301,406,602
    8 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor 161 Marsh Wall London E14 9AP England à 6th Floor 60 Gracechurch Street London EC3V 0HR le 20 août 2018

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name11 juin 2018

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de Lauren Ezrol Klein en tant que secrétaire le 31 janv. 2018

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Marcus Alvin Rich en tant que directeur le 13 mars 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stephen John May en tant que directeur le 13 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Joseph Henry Ceryanec en tant qu'administrateur le 15 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Stanley Zieser en tant qu'administrateur le 15 févr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Susana D'emic en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    15 pagesAA

    Modification des détails de Time Uk Publishing Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juin 2016

    2 pagesPSC05

    Notification de Time Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Qui sont les dirigeants de TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CERYANEC, Joseph Henry
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Administrateur
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican243478830001
    ZIESER, John Stanley
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    Administrateur
    60 Gracechurch Street
    EC3V 0HR London
    6th Floor
    England
    United StatesAmerican217687580001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Secrétaire
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Secrétaire
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Secrétaire
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Secrétaire
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    British36233000002
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Secrétaire
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Secrétaire
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Secrétaire
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Administrateur
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    British25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Administrateur
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    British78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Administrateur
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Administrateur
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsa127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Administrateur
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    British67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Administrateur
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmerican181954550002
    D'EMIC, Susana Alves
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Administrateur
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United StatesAmerican265525580001
    DAVISON, Guy Bryce
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    Administrateur
    128 Kensington Park Road
    W1 2EP London
    British48717030002
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Administrateur
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew Zealander70941240001
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Administrateur
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    LINDEN, Brian Andrew
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    Administrateur
    7 Westmoreland Road
    Barnes
    SW13 9RZ London
    United KingdomBritish36233000002
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Administrateur
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritish99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Administrateur
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    British40092920001
    MAY, Stephen John
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Administrateur
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritish173367920001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Administrateur
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritish189455000001
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    British11882410003
    RICH, Marcus Alvin
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Administrateur
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritish185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Administrateur
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsa111282190001
    WEBSTER, Evelyn Ann
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    Administrateur
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    EnglandBritish68847920003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TI MAGAZINES (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Time Uk Publishing Holdings Limited
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    04 juin 2016
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom Companies House
    Numéro d'enregistrement4203872
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Time Inc.
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    06 avr. 2016
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    Non
    Forme juridiqueCorporate
    Pays d'enregistrementState Of Delaware, Usa
    Autorité légaleState Of Delaware, Usa
    Lieu d'enregistrementState Of Delaware, Usa
    Numéro d'enregistrement13-3486363
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    TI MAGAZINES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 août 1999
    Livré le 02 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 02 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998)
    Créé le 12 oct. 1998
    Livré le 15 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 oct. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 janv. 1998
    Livré le 06 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the company(formerly known as excesstop limited) to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0