BRAITRIM HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRAITRIM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03484688 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Central Working White City Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2017 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB à Central Working White City Translation and Innovation Hub 80 Wood Lane London W12 0BZ le 10 janv. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 6Th Floor 10 Dominion Street London Uk EC2M 2EE United Kingdom à Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB | 1 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré Braitrim House 98 Victoria Road London NW10 6NB | 1 pages | AD04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graeme Andrew Scott Rutherford le 03 mars 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 juin 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Director Ben James Hunt en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Ente en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Joseph Murphy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 03 juil. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Ben James, Director | Administrateur | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | Hong Kong | British | 183078810001 | |||||
| RUTHERFORD, Graeme Andrew Scott | Administrateur | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | England | British | 137560120005 | |||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Secrétaire | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | British | 67243220003 | ||||||
| BONGIORNO, John Joseph | Secrétaire | 19a Selborne Road 3142 Toorak 3142 Victoria Australia | Australian | 94637000002 | ||||||
| CARSTENS, Andre | Secrétaire | Callantina Road 3122 Hawthorn 17 Victoria Australia | Australian | 122830070002 | ||||||
| DONEGAN, Steven Michael | Secrétaire | Fitzgibbon Crescent 3161 Caulfield North 28 Victoria Australia | Australian | 137561570001 | ||||||
| GIVONI, Michael Nathan | Secrétaire | Unit 2/6a St Leonard's Avenue 3182 St Kilda 3182 Australia | Australian | 122829370001 | ||||||
| MCDONALD, Wayne Douglas | Secrétaire | 13 Balfour Street Doncaster Victoria 3108 Australia | Australian | 94637090001 | ||||||
| MONTEITH, James Henry George | Secrétaire | 145 Rosendale Road Dulwich SE21 8HE London | British | 103511470001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Judith-Anne | Secrétaire | Level 3, 350 Queen St Melbourne Victoria 3000 Australia | British | 95244390004 | ||||||
| UNITE, Roger William | Secrétaire | 19 Bolton Gardens TW11 9AX Teddington Middlesex | British | 57486240001 | ||||||
| SISEC LIMITED | Secrétaire désigné | 21 Holborn Viaduct EC1A 2DY London | 900001770001 | |||||||
| ALLEN, Frank John | Administrateur | Kevali 13 Jeffries Court Hedsor Road SL8 5DY Bourne End Buckinghamshire | British | 42023240003 | ||||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Administrateur | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 67243220003 | |||||
| BLYTHE, Brian Stuart | Administrateur | 3568 Point Nepean Road Portsea Victoria 3944 Australia | Australian | 94637020001 | ||||||
| BONGIORNO, John Joseph | Administrateur | 19a Selborne Road 3142 Toorak 3142 Victoria Australia | Australian | 94637000002 | ||||||
| CARSTENS, Andre | Administrateur | Callantina Road 3122 Hawthorn 17 Victoria Australia | Australia | Australian | 122830070002 | |||||
| COLEMAN, John Ashley | Administrateur | Everington House Everington Hill RG18 0UD Yattendon Berkshire | England | British | 62128080003 | |||||
| COOK, Lynne Yvonne | Administrateur | 148 Evelyn Avenue HA4 0EP Ruislip Middlesex | British | 69384290002 | ||||||
| DAVIDSON, Steven | Administrateur | Hollyhurst Sandy Lane KT20 6NE Tadworth Surrey | England | English | 150579140001 | |||||
| DIBDEN, Lindsay George | Administrateur | Baigens GU34 1SL Chawton Alton Hampshire | British | 40399480002 | ||||||
| ENTE, Nicholas Johan | Administrateur | Braitrim House 98 Victoria Road NW10 6NB London | Australia | Australian | 168888010001 | |||||
| ENTE, Nicholas Johan | Administrateur | Pacific Place 88 Queensway Amiralty Apt 2500 Hong Kong | Hong Kong | Australian | 137561470003 | |||||
| EVANS, Ronald Barry | Administrateur | Apartment 11 Cairns Apartments 131 Hotham Street East Melbourne Victoria 3002 Australia | Australian | 94637070001 | ||||||
| FARNIK, Josef Peter | Administrateur | Garden Street 3141 South Yarra 44 Victoria Australia | Australia | Australian | 123638990003 | |||||
| FEIST, Roger | Administrateur | Thornacre Lodge EN5 3JZ Barnet Road Hertfordshire | British | 72466200001 | ||||||
| FEIST, Roger | Administrateur | Thornacre Lodge EN5 3JZ Barnet Road Hertfordshire | British | 72466200001 | ||||||
| GLYNN, Barry Allan | Administrateur | New House 32 New Road Digswell AL6 0AH Welwyn Hertfordshire | British | 28968220001 | ||||||
| MARTIN, Nicholas Rupert Zelenka | Administrateur | 123 Mallinson Road SW11 1BH London | British | 23175310002 | ||||||
| MONTEITH, James Henry George | Administrateur | 145 Rosendale Road Dulwich SE21 8HE London | England | British | 103511470001 | |||||
| MOORE, Peter Augustine | Administrateur | Orchards Milton Bryan MK17 9HS Milton Keynes Bedfordshire | British | 39904050001 | ||||||
| MURPHY, Joseph | Administrateur | Stuyvestant Circle East Setauket 1 New York United States Of America | Usa | American | 137559970001 | |||||
| NICHOLSON, Maurice Raymond Lawrence | Administrateur | 41 Polygon Road St Heliers Auckland New Zealand | New Zealander | 107215540001 | ||||||
| PADDISON, Jack Thomas Russell | Administrateur | Not Applicable 148 Evelyn Avenue HA4 8AA Ruislip Middlesex | British | 49157890003 | ||||||
| SHALSON, Peter | Administrateur | 26 Upper Brook Street W1K 7QE London | Great Britain | British | 76379940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRAITRIM HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Graeme Andrew Scott Rutherford | 06 avr. 2016 | Translation And Innovation Hub 80 Wood Lane W12 0BZ London Central Working White City England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
BRAITRIM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Créé le 08 mai 1998 Livré le 19 mai 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and the secured parties under the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions 1530 ord shares of $1 held by the chargor in the capital of the company with all the chargor's present and future rights including all securities all allotments all repayments all dividends. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 13 mars 1998 Livré le 21 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee as agent and security trustee for itself and each of the secured parties (as defined) under the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0