PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED

PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03486675
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    • (7310) /

    Où se situe PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PHOQUS PHARMACEUTICALS LIMITED27 nov. 200227 nov. 2002
    PHOQUS LIMITED29 déc. 199729 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 févr. 2010

    6 pages4.68

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    8 pages2.16B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 16 janv. 2009

    11 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    11 pages2.34B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    12 pages2.17B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    legacy

    8 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    23 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    20 pagesAA

    Statuts

    10 pagesMA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed phoqus pharmaceuticals LIMITED\certificate issued on 18/09/07
    2 pagesCERTNM

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    8 pages395

    legacy

    3 pages395

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    20 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    Qui sont les dirigeants de PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish70796290001
    LEATHERS, David Frederick James
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    Administrateur
    38 Jermyn Street
    SW1Y 6DN London
    EnglandBritish84070000003
    MASON, Richard Colin St Helier, Dr
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Miklstein Building
    Granta Park
    CB21 6GH Cambridge
    Cambridgeshire
    British122520900001
    MOSES, Edwin, Dr
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    Administrateur
    11 Court Gardens
    Cleeve Road
    RG8 9BZ Goring
    Oxfordshire
    British78748090004
    BRACE, Jacqueline Anne
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    Secrétaire
    87 Oakdene Avenue
    BR7 6DZ Chislehurst
    Kent
    British56818020001
    JOHNSON, Peter Graham, Dr
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    Hollybush House
    Crawley
    SO21 2QB Winchester
    Hampshire
    British70796290001
    SMITH, Suzanne Elaine
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    Secrétaire
    10 Kings Hill Avenue
    ME19 4AH West Malling
    Kent
    British119288360001
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Secrétaire désigné
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    ARMSTRONG, Frank Murdoch, Dr
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    Administrateur
    Phoqus Group Limited
    10 Kings Hill Avenue Kings Hill
    ME19 4PQ West Malling
    Kent
    British79589620003
    BENJAMIN, Jerry Christopher
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    2 Walnut Drive
    KT20 6QX Tadworth
    Surrey
    American34371910001
    BLAKER, Graham Joseph, Dr
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Callingham House
    17 Ledborough Lane
    HP9 2PZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish110270002
    BLANEY, Terence William Daniel
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    Administrateur
    Meadow Court
    Ranters Lane
    TN17 1HR Goudhurst
    Kent
    United KingdomBritish8680200001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CASHMAN, John Patrick
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    83 Ailesbury Road
    Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Irish85222710001
    CLOSE, Jon
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    Administrateur
    Warren House
    Castle Road
    TQ6 0DX Kingswear
    Dartmouth Devon
    British78001370001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    JONES, Andrew Alfred, Dr
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    Administrateur
    Stewarts Cottage
    Graffham
    GU28 0QE Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish84861540001
    MCLELLAND, Michael Bruce
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    Administrateur
    635 Leopard Road
    Berwyn Pa 19312
    Pennsylvania
    Usa
    American63138450001
    MOTZER, William Raymond
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    Administrateur
    1280 Turnbury Lane
    PA 19454 North Wales
    Pennsylvania
    Usa
    American17570280001
    SEAGER, Harry, Dr
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    Administrateur
    Ashley Lodge
    Ashley Box
    SN13 8AN Corsham
    Wiltshire
    British63260950001
    STANIFORTH, John Nicholas
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    Administrateur
    170 Bloomfield Road
    BA2 2AT Bath
    Avon
    British116945380001
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Administrateur désigné
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2007
    Livré le 05 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    10 kings hill avenue kings hill west mal. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Oxford Finance Corporation
    Transactions
    • 05 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 23 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Deposit balance and all amount standing to the credit of an interest bearing account.
    Personnes ayant droit
    • Kings Hill Trustee No 1 Limited and Kings Hill Trustee No 2 Limited
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of rent deposit
    Créé le 09 déc. 2004
    Livré le 14 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held.
    Personnes ayant droit
    • Liberty Property Limited Partnership
    Transactions
    • 14 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Security deed
    Créé le 23 juil. 2004
    Livré le 10 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from either obligor or both of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right, title and interest in and to each machine and all related rights relating to each machine but excluding any intellectual property in the design or operation of the machines. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cardinal Health U.K. 416 Limited
    Transactions
    • 10 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 sept. 2002
    Livré le 26 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gatx European Technology Ventures
    Transactions
    • 26 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rent deposit
    Créé le 09 août 2002
    Livré le 14 août 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance is held opened in the name of liberty property limited partnership.
    Personnes ayant droit
    • Liberty Property Limited Partnership
    Transactions
    • 14 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of rent deposit supplemental to a lease
    Créé le 04 juil. 2002
    Livré le 10 juil. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest from time to time standing to the credit of an interest bearing account where the deposit balance.
    Personnes ayant droit
    • Rouse Kent (Central) Limited
    Transactions
    • 10 juil. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 mai 2001
    Livré le 17 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities (whether present or future actual or contingent) now or at any time or times hereafter due owing or incurred by the company (whether as principal or surety) to the security trustee or any of the lenders pursuant to the terms of the investment agreement as amended from time to time dated 29/01/01
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2001
    Livré le 07 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the investment agreement dated 30 january 2001 ("the investment agreement") and/or the debenture (other than a dividend on any shares)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • 3I PLC ("the Security Trustee") (Acting for Itself and as Trustee on Behalf of the Lenders)
    Transactions
    • 07 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 sept. 2000
    Livré le 28 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Gatx European Technology Ventures
    Transactions
    • 28 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2000Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 06 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PHOQUS PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 juil. 2008Administration started
    23 févr. 2009Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Martin Gilbert Ellis
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    practitioner
    30 Finsbury Square
    London
    EC2P 2YU
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DateType
    23 févr. 2009Commencement of winding up
    15 juin 2010Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew Lawrence Hosking
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0