LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)

LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES)
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité illimitée
    Numéro de société 03487186
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Adresse du siège social
    18 Smith Square
    SW1P 3HZ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) LIMITED22 déc. 199722 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    20 pagesAA

    Notification de Local Government Association en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 févr. 2019

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 05 déc. 2019

    2 pagesPSC09

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Cllr Nicholas Darby le 01 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    18 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Proctor en tant qu'administrateur le 20 août 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Cllr Nicholas Darby en tant qu'administrateur le 27 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas John Dixon Chard en tant que directeur le 24 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Attribution d'une nouvelle catégorie d'actions par une société en nom collectif

    3 pagesSH09

    Re-enregistrement de l'assentiment

    1 pagesFOA-RR

    Certificat de réimmatriculation de société à responsabilité limitée à société de personnes à responsabilité illimitée

    1 pagesCERT3

    Réenregistrement des statuts

    24 pagesMAR

    Re-enregistrement d'une société à responsabilité limitée privée en société à responsabilité illimitée privée

    2 pagesRR05

    Cessation de la nomination de Clarence Cornelius Barrett en tant que directeur le 08 mars 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2017

    117 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOLLOWAY, Claire
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Secrétaire
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    197947830001
    DARBY, Nicholas, Cllr
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Administrateur
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    EnglandBritish261356930001
    NEIGHBOUR, David Alan
    Harlington Way
    GU51 4AE Fleet
    Civic Offices Hart District Council
    Hants
    United Kingdom
    Administrateur
    Harlington Way
    GU51 4AE Fleet
    Civic Offices Hart District Council
    Hants
    United Kingdom
    United KingdomBritish184778450001
    PICKUP, Sarah Jane
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Administrateur
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    EnglandBritish202250060001
    PROCTOR, Andrew James
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Administrateur
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomEnglish261412110001
    SWITHENBANK, Ian Carr Fry
    68 Porchester Drive
    NE23 9QH Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    68 Porchester Drive
    NE23 9QH Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritish33820940001
    DOWNS, Carolyn Grace
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Secrétaire
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    British165714430001
    PLATTS, Helen Jane
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Local Government House
    Secrétaire
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Local Government House
    British176329670001
    RANSFORD, John Anthony
    17 Saint Marys
    YO30 7DD York
    North Yorkshire
    Secrétaire
    17 Saint Marys
    YO30 7DD York
    North Yorkshire
    British120473470001
    REES, John
    21 The Greenway
    UB8 2PH Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    21 The Greenway
    UB8 2PH Uxbridge
    Middlesex
    British16258840001
    BARRETT, Clarence Cornelius, Councillor
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Administrateur
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomBritish236911420001
    BRISCOE, Brian Anthony
    257 Boxley Road
    ME14 2AS Maidstone
    Temple House
    Kent
    Administrateur
    257 Boxley Road
    ME14 2AS Maidstone
    Temple House
    Kent
    EnglandBritish56159320004
    CHARD, Nicholas John Dixon
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Administrateur
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    United KingdomBritish94511710001
    COEN, Paul
    The Russetts
    Mayes Lane
    CM3 4NJ Danbury
    Essex
    Administrateur
    The Russetts
    Mayes Lane
    CM3 4NJ Danbury
    Essex
    British114793600001
    DOWNS, Carolyn Grace
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish165498040001
    GEE, Ronald Stanley
    35 Gadesden Road
    West Ewell
    KT19 9LB Epsom
    Surrey
    Administrateur
    35 Gadesden Road
    West Ewell
    KT19 9LB Epsom
    Surrey
    British43475450001
    HANNINGFIELD, The Lord, The Rt Hon
    Pippins Place
    Helmons Lane, West Hanningfield
    CM2 8UW Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    Pippins Place
    Helmons Lane, West Hanningfield
    CM2 8UW Chelmsford
    Essex
    United KingdomBritish77930920001
    HUGHES, Stephen Edward
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    United KingdomBritish112164350001
    JACKSON, Anthony Peter
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish140431600001
    JONES, Harry, Sir
    8 Beaufort Place
    NP9 7NB Newport
    Gwent
    Administrateur
    8 Beaufort Place
    NP9 7NB Newport
    Gwent
    WalesBritish16605380001
    JONES, Stephen William
    1 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EB Woking
    Surrey
    Administrateur
    1 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EB Woking
    Surrey
    United KingdomBritish123054070001
    LAMBERT, Claire
    Starveall Farm
    Oxford Road Stone
    HP17 8PZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Starveall Farm
    Oxford Road Stone
    HP17 8PZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish101232430001
    MITCHELL, Keith Ronald
    New Road
    OX17 3NU Oxford
    Leaders Office County Hall
    Oxfordshire
    Administrateur
    New Road
    OX17 3NU Oxford
    Leaders Office County Hall
    Oxfordshire
    United KingdomBritish136157500001
    NAYLOR, Adrian
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish199102380001
    ROE, Philippa Marion, Cllr
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish131976560001
    THORNBER, Thomas Kenneth, Councillor
    Back Lane
    Sway
    SO41 6BU Lymington
    Myrtle Cottage
    Hampshire
    Britain
    Administrateur
    Back Lane
    Sway
    SO41 6BU Lymington
    Myrtle Cottage
    Hampshire
    Britain
    EnglandBritish184079310001
    THORNTON, James Douglas
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish72854560001
    WHITE, Christopher, Councillor
    17 Cunningham Avenue
    AL1 1JJ St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Cunningham Avenue
    AL1 1JJ St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish102094030002
    WHITEMAN, Milner, Cllr
    Arlescott Farm
    TF12 5BG Broseley
    Shropshire
    Administrateur
    Arlescott Farm
    TF12 5BG Broseley
    Shropshire
    British86513060001
    WHITHAM, Graham George, Councillor
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    Administrateur
    Local Goverment House
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    EnglandBritish203071600001
    WILLIAMS, David Reeve, Sir
    8 Arlington Road
    Petersham
    TW10 7BY Richmond
    Surrey
    Administrateur
    8 Arlington Road
    Petersham
    TW10 7BY Richmond
    Surrey
    EnglandBritish16773620001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    17 févr. 2019
    Smith Square
    SW1P 3HZ London
    18
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Unlimited Company Without Share Capital
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompay Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement11177145
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 nov. 201619 févr. 2019La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    LOCAL GOVERNMENT ASSOCIATION (PROPERTIES) a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 21 janv. 2000
    Livré le 25 janv. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement or any hedging agreements (as defined in the loan agreement dated 20TH january 2000)
    Brèves mentions
    Local government house (formerly transport house) smith square london t/no NGL374544 with all fixed plant & machinery and fixtures thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 janv. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 1999
    Livré le 10 avr. 1999
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to an agreement dated 22ND january 1998
    Brèves mentions
    The whole of the land and buildings thereon at smith square london SW1 t/n NGL374544 the whole of the company's undertaking and all its property and assets whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Association of Metropolitan Authorities (Properties) Limited
    Transactions
    • 10 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a transport house smith square london SW1 t/no;-NGL374544 the proceeds of sale thereof goodwill benefit of all licences. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 05 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transactions
    • 05 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 27 janv. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,900,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Transport house smith square westminster london.
    Personnes ayant droit
    • Bernard Passingham
    • Charles Bernard Pitson
    • Raymond Frank Deaves
    Transactions
    • 27 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 22 janv. 1998
    Livré le 24 janv. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to an agreement dated 22ND january 1998
    Brèves mentions
    The whole of the land and buildings at smith square london t/no NGL374544 and a floating charge the undertaking property and assets.
    Personnes ayant droit
    • Acc Properties Limited
    Transactions
    • 24 janv. 1998Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0