MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03488633 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Peter Ashbrook le 01 mai 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 01 juin 2016 | 20 pages | RP04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 17 févr. 2016
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr John Ivor Cavill en tant qu'administrateur le 25 janv. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Biif Corporate Services Limited en tant que directeur le 25 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Biif Corporate Services Limited le 01 juil. 2015 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , C/O Dundas & Wilson, Northwest Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ à Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF le 01 juil. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Peter Ashbrook le 01 sept. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mr Philip Peter Ashbrook en tant qu'administrateur le 25 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard David Hoile en tant que directeur le 25 juil. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 17 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , C/O Dundas & Wilson, North West Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ le 27 août 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 17 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secrétaire | Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| ASHBROOK, Philip Peter | Administrateur | 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 121252960004 | |||||||||
| BALDOCK, Graham | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | United Kingdom | British | 49519600001 | |||||||||
| CAVILL, John Ivor | Administrateur | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | England | British | 152521640008 | |||||||||
| BESWICK, Nigel Lloyd | Secrétaire | 44 Brantwood Road Herne Hill SE24 0DJ London | British | 56835390001 | ||||||||||
| COOKE, David John | Secrétaire | 31 Foxborough Swallowfield RG7 1RW Reading Berkshire | British | 83213800001 | ||||||||||
| MOORE, William Edmond | Secrétaire | 35 Black Acre Close HP7 9EW Amersham Buckinghamshire | British | 114630630002 | ||||||||||
| TODD, Francesca Anne | Secrétaire | 26 Glebe Road SM2 7NT Cheam Surrey | British | 72249980001 | ||||||||||
| ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secrétaire désigné | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||||||
| BAILEY, Carol Elaine | Administrateur | Apt 24 Claremont Lodge 15 The Downs SW20 8UA London | British | 93650840001 | ||||||||||
| BAILEY, Carol Elaine | Administrateur | 193 Cottenham Park Road SW20 0SY London | England | British | 9905530001 | |||||||||
| BESWICK, Nigel Lloyd | Administrateur | 44 Brantwood Road Herne Hill SE24 0DJ London | United Kingdom | British | 56835390001 | |||||||||
| CALABRESE, Wayne Howard | Administrateur | 193 Ocean Key Way 33477 Jupiter Florida Usa | United States | American | 30780670003 | |||||||||
| CARTER, James Duncan | Administrateur | The Slopes Charterhouse Road GU7 2AW Godalming Surrey | British | 93908800001 | ||||||||||
| CORNWELL, Anthony Bruce | Administrateur | The Cottage 134 London Road GU19 5BZ Bagshot Surrey | United Kingdom | British | 3471920001 | |||||||||
| CRAWSHAW, Andrew Julian | Administrateur | 16 Bartley Wood Business Park Bartley Way RG27 9UY Hook Serco House Hampshire | England | British | 130322170001 | |||||||||
| EDWARDS, Philip John | Administrateur | 430 Yorktown Road GU47 0PR Sandhurst Berkshire | British | 87032350001 | ||||||||||
| FUTCHER, William Frank | Administrateur | 1 Beech Park HP6 6PY Amersham Buckinghamshire | British | 51346890001 | ||||||||||
| HAGA, Thomas Justin | Administrateur | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London North West Wing Bush House | United Kingdom | British | 111282640001 | |||||||||
| HAYWARD, Neil | Administrateur | 21 Gibbon Road KT2 6AD Kingston Upon Thames Surrey | British | 144924760001 | ||||||||||
| HILL, Gavin | Administrateur | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | 84457250005 | |||||||||
| HOILE, Richard David | Administrateur | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London Northwest Wing Bush House United Kingdom | United Kingdom | British | 137848430002 | |||||||||
| JEFFERY, John Daniel Michael | Administrateur | Fairpark House 18 Green Lane KT11 2NN Cobham Surrey | British | 93851850002 | ||||||||||
| KEENS, Donald Herbert | Administrateur | 7807 Ironhorse Boulevard West Palm Beach 33412 Usa | British | 70256340003 | ||||||||||
| LEACH, Guy William | Administrateur | Apartment D162 Parliment View Apartments 1 Albert Embankment SE1 7XQ London | British | 70877660003 | ||||||||||
| LEWIS, Kevin Tony | Administrateur | 36 Woodbury Road St Ives New South Wales 2075 Australia | Australian | 86468730001 | ||||||||||
| LEWIS, Kevin Tony | Administrateur | Boanti House Swallowfield Street RG7 1QX Swallowfield Berkshire | Australian | 52036330001 | ||||||||||
| MCDONAGH, John | Administrateur | 30 St Botolph's Road Sevenoaks TN13 3AG Kent | British | 116580030002 | ||||||||||
| MCNAUGHT, William Wright | Administrateur | 14 Church Road East GU14 6QJ Farnborough Hampshire | British | 52531510002 | ||||||||||
| MEAD, Mark William | Administrateur | 28 The Burlings SL5 8BY Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 151850410001 | |||||||||
| MIDDLETON, Nigel Wythen | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 156912990001 | |||||||||
| REICHERTER, Matthias Alexander | Administrateur | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | German | 138502740001 | |||||||||
| RIALL, Thomas Richard Phineas | Administrateur | Serco House Bartley Wood Business Park, Bartley Way RG27 9UY Hook Hampshire | United Kingdom | British | 76434190002 | |||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Administrateur | Central Building 3 Matthew Parker Street SW1H 9NE London Apartment 42, | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| SMITH, John | Administrateur | 4 Longwater Lane RG40 4NZ Finchampstead Berkshire | British | 95897660001 |
MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Créé le 02 déc. 2006 Livré le 07 déc. 2006 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from pcfl to the security trustee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the company's right,title and interest,present and future,in.under and to the relevant contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of release and counter-indemnity | Créé le 17 sept. 2003 Livré le 03 oct. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the senior charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of release and counter-indemnity | Créé le 17 sept. 2003 Livré le 03 oct. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the subordinated charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A subordinated fixed and floating charge | Créé le 12 nov. 1998 Livré le 27 nov. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under each or any of the financing agreements | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of fixed charge | Créé le 12 nov. 1998 Livré le 20 nov. 1998 | En cours | Montant garanti All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement of even date ("the dcmf contract") | |
Brèves mentions All the companys right title and interest in and to the equipment (as defined therein). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 12 nov. 1998 Livré le 25 nov. 1998 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) under each or any of the financing agreements | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0