MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03488633
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDOMSLEY SECURE TRAINING SERVICES LIMITED13 mars 199813 mars 1998
    ALNERY NO. 1734 LIMITED05 janv. 199805 janv. 1998

    Quels sont les derniers comptes de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Peter Ashbrook le 01 mai 2016

    2 pagesCH01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 01 juin 2016

    20 pagesRP04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 juin 2016

    État du capital au 06 juin 2016

    • Capital: GBP 200,000
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    16 juin 2016Clarification A second filed AR01 was registered on 16/06/2016.

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 17 févr. 2016

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Nomination de Mr John Ivor Cavill en tant qu'administrateur le 25 janv. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Biif Corporate Services Limited en tant que directeur le 25 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Biif Corporate Services Limited le 01 juil. 2015

    1 pagesCH02

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Dundas & Wilson, Northwest Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ à Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF le 01 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Peter Ashbrook le 01 sept. 2014

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Philip Peter Ashbrook en tant qu'administrateur le 25 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard David Hoile en tant que directeur le 25 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 juin 2014

    État du capital au 18 juin 2014

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , C/O Dundas & Wilson, North West Wing Bush House Aldwych, London, WC2B 4EZ le 27 août 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05372427
    128530180002
    ASHBROOK, Philip Peter
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    Administrateur
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish121252960004
    BALDOCK, Graham
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish49519600001
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Secrétaire
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    British56835390001
    COOKE, David John
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    31 Foxborough
    Swallowfield
    RG7 1RW Reading
    Berkshire
    British83213800001
    MOORE, William Edmond
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    35 Black Acre Close
    HP7 9EW Amersham
    Buckinghamshire
    British114630630002
    TODD, Francesca Anne
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    Secrétaire
    26 Glebe Road
    SM2 7NT Cheam
    Surrey
    British72249980001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire désigné
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BAILEY, Carol Elaine
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    Administrateur
    Apt 24 Claremont Lodge
    15 The Downs
    SW20 8UA London
    British93650840001
    BAILEY, Carol Elaine
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    Administrateur
    193 Cottenham Park Road
    SW20 0SY London
    EnglandBritish9905530001
    BESWICK, Nigel Lloyd
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Administrateur
    44 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United KingdomBritish56835390001
    CALABRESE, Wayne Howard
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    Administrateur
    193 Ocean Key Way
    33477 Jupiter
    Florida
    Usa
    United StatesAmerican30780670003
    CARTER, James Duncan
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    Administrateur
    The Slopes
    Charterhouse Road
    GU7 2AW Godalming
    Surrey
    British93908800001
    CORNWELL, Anthony Bruce
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    Administrateur
    The Cottage 134 London Road
    GU19 5BZ Bagshot
    Surrey
    United KingdomBritish3471920001
    CRAWSHAW, Andrew Julian
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    Administrateur
    16 Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Serco House
    Hampshire
    EnglandBritish130322170001
    EDWARDS, Philip John
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    Administrateur
    430 Yorktown Road
    GU47 0PR Sandhurst
    Berkshire
    British87032350001
    FUTCHER, William Frank
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    1 Beech Park
    HP6 6PY Amersham
    Buckinghamshire
    British51346890001
    HAGA, Thomas Justin
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    Administrateur
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish111282640001
    HAYWARD, Neil
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    Administrateur
    21 Gibbon Road
    KT2 6AD Kingston Upon Thames
    Surrey
    British144924760001
    HILL, Gavin
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish84457250005
    HOILE, Richard David
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    Northwest Wing Bush House
    United Kingdom
    United KingdomBritish137848430002
    JEFFERY, John Daniel Michael
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Fairpark House
    18 Green Lane
    KT11 2NN Cobham
    Surrey
    British93851850002
    KEENS, Donald Herbert
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    Administrateur
    7807 Ironhorse Boulevard
    West Palm Beach
    33412
    Usa
    British70256340003
    LEACH, Guy William
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    Administrateur
    Apartment D162 Parliment View
    Apartments 1 Albert Embankment
    SE1 7XQ London
    British70877660003
    LEWIS, Kevin Tony
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Administrateur
    36 Woodbury Road
    St Ives
    New South Wales 2075
    Australia
    Australian86468730001
    LEWIS, Kevin Tony
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Administrateur
    Boanti House
    Swallowfield Street
    RG7 1QX Swallowfield
    Berkshire
    Australian52036330001
    MCDONAGH, John
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    Administrateur
    30 St Botolph's Road
    Sevenoaks
    TN13 3AG Kent
    British116580030002
    MCNAUGHT, William Wright
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    14 Church Road East
    GU14 6QJ Farnborough
    Hampshire
    British52531510002
    MEAD, Mark William
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    28 The Burlings
    SL5 8BY Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish151850410001
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish156912990001
    REICHERTER, Matthias Alexander
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Administrateur
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomGerman138502740001
    RIALL, Thomas Richard Phineas
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Serco House
    Bartley Wood Business Park, Bartley Way
    RG27 9UY Hook
    Hampshire
    United KingdomBritish76434190002
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Administrateur
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SMITH, John
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    Administrateur
    4 Longwater Lane
    RG40 4NZ Finchampstead
    Berkshire
    British95897660001

    MEDOMSLEY TRAINING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security assignment
    Créé le 02 déc. 2006
    Livré le 07 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from pcfl to the security trustee and the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's right,title and interest,present and future,in.under and to the relevant contract. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 03 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the senior charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Banks
    Transactions
    • 03 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of release and counter-indemnity
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 03 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the company's present and future rights in claims under the benefit of the deed of release in accordance with and subject to the terms and conditions of the subordinated charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Serco Investments Limited as Subordinated Security Trustee on Behalf of the Lenders
    Transactions
    • 03 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    A subordinated fixed and floating charge
    Créé le 12 nov. 1998
    Livré le 27 nov. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under each or any of the financing agreements
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Serco Investments Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 27 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of fixed charge
    Créé le 12 nov. 1998
    Livré le 20 nov. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to clause 17.2 of the agreement of even date ("the dcmf contract")
    Brèves mentions
    All the companys right title and interest in and to the equipment (as defined therein).
    Personnes ayant droit
    • Her Majesty's Principal Secretary of State for the Home Department
    Transactions
    • 20 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed and floating charge
    Créé le 12 nov. 1998
    Livré le 25 nov. 1998
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the agent) under each or any of the financing agreements
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0