SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03491956
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EQUINOX CONVERGED SOLUTIONS LIMITED15 mai 200115 mai 2001
    EFORCE LIMITED19 juin 200019 juin 2000
    EQUINOX SOLUTIONS SERVICES LIMITED09 avr. 199909 avr. 1999
    BUDGET COMMUNICATIONS LIMITED03 févr. 199803 févr. 1998

    Quels sont les derniers comptes de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 30 Berners Street London W1T 3LR

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 30 Berners Street London W1T 3LR

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 30 Berners Street London W1T 3LR England à 1 More London Place London SE1 2AF le 10 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Re-capitalise £8852000 05/12/2019
    RES14

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 déc. 2019

    • Capital: GBP 2
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 05 déc. 2019

    • Capital: GBP 8,852,002
    3 pagesSH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Capita Corporate Director Limited le 15 juin 2018

    1 pagesCH02

    Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 15 juin 2018

    1 pagesCH04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Francesca Anne Todd le 15 juin 2018

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 17-19 Rochester Row London SW1P 1QT à 30 Berners Street London W1T 3LR le 15 juin 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    1 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Secrétaire
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishCompany Secretary72249980003
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Administrateur
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement5641516
    129795770003
    HART, Amanda Judith
    5 Grange Close
    SO23 9RS Winchester
    Hampshire
    Secrétaire
    5 Grange Close
    SO23 9RS Winchester
    Hampshire
    BritishChartered Accountant80624240001
    HEARD, Oliver Marc
    14 Woodlands
    GU46 6DD Yateley
    Hampshire
    Secrétaire
    14 Woodlands
    GU46 6DD Yateley
    Hampshire
    British106971280001
    JONES, Nigel Lawrence
    4 Heather Close
    GU9 8SD Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    4 Heather Close
    GU9 8SD Farnham
    Surrey
    British33423680001
    PERKINS, Stephen
    Cricketers Cottage
    GU8 4DQ Shalford
    Surrey
    Secrétaire
    Cricketers Cottage
    GU8 4DQ Shalford
    Surrey
    BritishAccountant107478300001
    CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    The Registry
    Kent
    England
    Secrétaire
    34 Beckenham Road
    BR3 4TU Beckenham
    The Registry
    Kent
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05306796
    102944500001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secrétaire désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BANKS, John Allen
    24 Millington Road
    Newnham
    CB3 9HP Cambridge
    Cambridgeshire
    Administrateur
    24 Millington Road
    Newnham
    CB3 9HP Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director45159280001
    CONWAY, Christopher John
    32 Pensford Avenue
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    Administrateur
    32 Pensford Avenue
    TW9 4HP Richmond
    Surrey
    United KingdomIrishChairman69898690001
    CROOK, Duncan Timothy
    The Old Henwick Cottage
    Ashmore Green Road
    RG18 9ER Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    The Old Henwick Cottage
    Ashmore Green Road
    RG18 9ER Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director55940980002
    DUNWOODY, Steven
    3 New Road
    Forest Green
    RH5 5SA Dorking
    Surrey
    Administrateur
    3 New Road
    Forest Green
    RH5 5SA Dorking
    Surrey
    BritishTechnical Director76042050002
    FAHEY, David Anthony
    8 Lynham Way
    CW3 9HX Madeley
    Administrateur
    8 Lynham Way
    CW3 9HX Madeley
    United KingdomBritishAccountant102331790001
    FLOYDD, William James Spencer
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector179831560001
    GRABINER, Michael
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    Administrateur
    35 Uphill Road
    Mill Hill
    NW7 4RA London
    United KingdomBritishVenture Capitalist82032360001
    GRANT, David Paul
    Hurdle Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Hurdle Cottage
    Elm Close
    SL2 3NA Farnham Common
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director77340890001
    HANDS, Peter Edward
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    England
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    England
    England
    United KingdomBritishManaging Director177131690001
    HART, Amanda Judith
    5 Grange Close
    SO23 9RS Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    5 Grange Close
    SO23 9RS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishAccountant80624240001
    HEWETT, Lee
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    EnglandBritishCompany Director134413590001
    HOSIE, Michael Douglas
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    Administrateur
    Woodbine Cottage The Long Road
    GU10 4DL Rowledge
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant23706640001
    HVASS, Andrew Per
    The Old Rectory
    Main Street
    LE67 2TB Normanton Le Heath
    Leicestershire
    Administrateur
    The Old Rectory
    Main Street
    LE67 2TB Normanton Le Heath
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector167960340001
    JADAVJI, Alex James
    Cleve Road
    NW6 3RR London
    6
    United Kingdom
    Administrateur
    Cleve Road
    NW6 3RR London
    6
    United Kingdom
    BritishChief Executive Officer110400820003
    KEARSEY, Sion Paul
    7 Park Square West
    NW1 4LJ London
    Administrateur
    7 Park Square West
    NW1 4LJ London
    BritishDirector86251600001
    MCMONIGALL, John Phillips
    Dipley Mill
    Dipley Road
    RG27 8JP Hartley Witney
    Hampshire
    Administrateur
    Dipley Mill
    Dipley Road
    RG27 8JP Hartley Witney
    Hampshire
    United KingdomBritishVenture Capitalist154220150001
    MERELIE, Angus Peter
    14 Elliswick Road
    AL5 4TP Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 Elliswick Road
    AL5 4TP Harpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director84854850001
    MOGG, Richard David
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector159395950001
    PARKER, Andrew George
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    United KingdomBritishFinance Director115610090003
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    Administrateur
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17-19
    United KingdomBritishChartered Accountant132651920002
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    Administrateur
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    United KingdomBritishChartered Accountant132651920002
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Administrateur désigné
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ellismuir Way
    Tannochside Park
    G71 5PW Glasgow
    Pavilion Building
    Uddingston
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Ellismuir Way
    Tannochside Park
    G71 5PW Glasgow
    Pavilion Building
    Uddingston
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc045439
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 mai 2006
    Livré le 19 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    All monies (non-bank) debenture
    Créé le 28 mai 2003
    Livré le 04 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All trade debts (including receivables and contingent receivables). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Thus PLC
    Transactions
    • 04 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    All monies (non-bank) debenture
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 14 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over all trade book debts including receivables and contingent receivables now and in the future due or owing to the company together with the benefit of all claims and rights relating thereto;.
    Personnes ayant droit
    • Redrock Networks Limited
    Transactions
    • 14 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 déc. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 16 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 16 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Chattel mortgage
    Créé le 03 mai 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The plant machinery chattels motor vehicles or other equipment described in schedule 1 of the charge together with all additions alterations accessories replacements and renewals from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Equinox Solutions Through Partnership Limited
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 03 mai 2002
    Livré le 08 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The plant machinery chattels motor vehicles or other equipment described in schedule 1 of the charge together with all additions alterations accessories replacements and renewals from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 08 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 avr. 2002
    Livré le 19 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £147,627 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    £147,627 and any additional amounts.
    Personnes ayant droit
    • Equitas Management Service Limited
    Transactions
    • 19 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over credit balances
    Créé le 07 nov. 2001
    Livré le 21 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    £63,000 with interest to be held by the bank on account no 78343836 and earmarked or designated by reference to the company.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 10 mai 2001
    Livré le 29 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a financing agreement of even date
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Commercial Finance
    Transactions
    • 29 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 déc. 2019Commencement of winding up
    18 févr. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0