SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03491956 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?
Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 30 Berners Street London W1T 3LR | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 30 Berners Street London W1T 3LR | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 30 Berners Street London W1T 3LR England à 1 More London Place London SE1 2AF le 10 janv. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 12 déc. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 05 déc. 2019
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 8 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Capita Corporate Director Limited le 15 juin 2018 | 1 pages | CH02 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Capita Group Secretary Limited le 15 juin 2018 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Francesca Anne Todd le 15 juin 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 17-19 Rochester Row London SW1P 1QT à 30 Berners Street London W1T 3LR le 15 juin 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Berners Street W1T 3LR London 30 England |
| 135207160001 | ||||||||||
TODD, Francesca Anne | Administrateur | More London Place SE1 2AF London 1 | England | British | Company Secretary | 72249980003 | ||||||||
CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Administrateur | Berners Street W1T 3LR London 30 England |
| 129795770003 | ||||||||||
HART, Amanda Judith | Secrétaire | 5 Grange Close SO23 9RS Winchester Hampshire | British | Chartered Accountant | 80624240001 | |||||||||
HEARD, Oliver Marc | Secrétaire | 14 Woodlands GU46 6DD Yateley Hampshire | British | 106971280001 | ||||||||||
JONES, Nigel Lawrence | Secrétaire | 4 Heather Close GU9 8SD Farnham Surrey | British | 33423680001 | ||||||||||
PERKINS, Stephen | Secrétaire | Cricketers Cottage GU8 4DQ Shalford Surrey | British | Accountant | 107478300001 | |||||||||
CAPITA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 34 Beckenham Road BR3 4TU Beckenham The Registry Kent England |
| 102944500001 | ||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
BANKS, John Allen | Administrateur | 24 Millington Road Newnham CB3 9HP Cambridge Cambridgeshire | British | Company Director | 45159280001 | |||||||||
CONWAY, Christopher John | Administrateur | 32 Pensford Avenue TW9 4HP Richmond Surrey | United Kingdom | Irish | Chairman | 69898690001 | ||||||||
CROOK, Duncan Timothy | Administrateur | The Old Henwick Cottage Ashmore Green Road RG18 9ER Newbury Berkshire | British | Company Director | 55940980002 | |||||||||
DUNWOODY, Steven | Administrateur | 3 New Road Forest Green RH5 5SA Dorking Surrey | British | Technical Director | 76042050002 | |||||||||
FAHEY, David Anthony | Administrateur | 8 Lynham Way CW3 9HX Madeley | United Kingdom | British | Accountant | 102331790001 | ||||||||
FLOYDD, William James Spencer | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 179831560001 | ||||||||
GRABINER, Michael | Administrateur | 35 Uphill Road Mill Hill NW7 4RA London | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 82032360001 | ||||||||
GRANT, David Paul | Administrateur | Hurdle Cottage Elm Close SL2 3NA Farnham Common Buckinghamshire | British | Company Director | 77340890001 | |||||||||
HANDS, Peter Edward | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 England England | United Kingdom | British | Managing Director | 177131690001 | ||||||||
HART, Amanda Judith | Administrateur | 5 Grange Close SO23 9RS Winchester Hampshire | England | British | Accountant | 80624240001 | ||||||||
HEWETT, Lee | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17-19 | England | British | Company Director | 134413590001 | ||||||||
HOSIE, Michael Douglas | Administrateur | Woodbine Cottage The Long Road GU10 4DL Rowledge Surrey | England | British | Chartered Accountant | 23706640001 | ||||||||
HVASS, Andrew Per | Administrateur | The Old Rectory Main Street LE67 2TB Normanton Le Heath Leicestershire | England | British | Director | 167960340001 | ||||||||
JADAVJI, Alex James | Administrateur | Cleve Road NW6 3RR London 6 United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 110400820003 | |||||||||
KEARSEY, Sion Paul | Administrateur | 7 Park Square West NW1 4LJ London | British | Director | 86251600001 | |||||||||
MCMONIGALL, John Phillips | Administrateur | Dipley Mill Dipley Road RG27 8JP Hartley Witney Hampshire | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 154220150001 | ||||||||
MERELIE, Angus Peter | Administrateur | 14 Elliswick Road AL5 4TP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 84854850001 | ||||||||
MOGG, Richard David | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | Director | 159395950001 | ||||||||
PARKER, Andrew George | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17-19 | United Kingdom | British | Finance Director | 115610090003 | ||||||||
SHEARER, Richard John | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17-19 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 132651920002 | ||||||||
SHEARER, Richard John | Administrateur | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 132651920002 | ||||||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Administrateur désigné | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capita It Services Limited | 06 avr. 2016 | Ellismuir Way Tannochside Park G71 5PW Glasgow Pavilion Building Uddingston United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 12 mai 2006 Livré le 19 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All monies (non-bank) debenture | Créé le 28 mai 2003 Livré le 04 juin 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All trade debts (including receivables and contingent receivables). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All monies (non-bank) debenture | Créé le 06 janv. 2003 Livré le 14 janv. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Floating charge over all trade book debts including receivables and contingent receivables now and in the future due or owing to the company together with the benefit of all claims and rights relating thereto;. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 09 mai 2002 Livré le 16 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 03 mai 2002 Livré le 08 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The plant machinery chattels motor vehicles or other equipment described in schedule 1 of the charge together with all additions alterations accessories replacements and renewals from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 03 mai 2002 Livré le 08 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The plant machinery chattels motor vehicles or other equipment described in schedule 1 of the charge together with all additions alterations accessories replacements and renewals from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 05 avr. 2002 Livré le 19 avr. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti £147,627 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions £147,627 and any additional amounts. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over credit balances | Créé le 07 nov. 2001 Livré le 21 nov. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions £63,000 with interest to be held by the bank on account no 78343836 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All assets debenture | Créé le 10 mai 2001 Livré le 29 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under a financing agreement of even date | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SYNETRIX (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0