NPS (UK5) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNPS (UK5) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03495019
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NPS (UK5) LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe NPS (UK5) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NPS (UK5) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORTHGATE PUBLIC SECTOR LIMITED28 nov. 200828 nov. 2008
    ANITE PUBLIC SECTOR LIMITED02 févr. 200002 févr. 2000
    IMASYS LIMITED16 févr. 199816 févr. 1998
    IMASYS (LOCAL GOVERNMENT) LIMITED14 janv. 199814 janv. 1998

    Quels sont les derniers comptes de NPS (UK5) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour NPS (UK5) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4NW à 15 Canada Square London E14 5GL le 03 juil. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juin 2019

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 avr. 2018

    2 pagesAA

    Période comptable actuelle raccourcie du 30 avr. 2019 au 31 mars 2019

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Ian Michael Noble en tant que directeur le 06 août 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen James Callaghan le 06 août 2018

    2 pagesCH01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 30 avr. 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    5 pagesAA

    Nomination de Ian Michael Noble en tant qu'administrateur le 06 déc. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Coll en tant que directeur le 06 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 26 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Stephen James Callaghan en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Meaden en tant que directeur le 10 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2015

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 janv. 2016

    État du capital au 04 janv. 2016

    • Capital: GBP 61,686,134.332
    SH01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed northgate public sector LIMITED\certificate issued on 16/06/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name16 juin 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2014

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    legacy

    pagesANNOTATION

    Qui sont les dirigeants de NPS (UK5) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2318923
    76579530001
    CALLAGHAN, Stephen James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish201347710052
    COUTTS, Cheryl Jane
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    Secrétaire
    6 Esmond Road
    W4 1JQ Chiswick
    London
    British12016130002
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    HEMMING, Vivienne Ruth
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    Secrétaire
    25 Saint Johns Road
    OX10 9AW Wallingford
    Oxon
    British41962390006
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Secrétaire
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    British32877720003
    RICHARDSON, John David
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    British128558470001
    SADLER, John Michael
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    14 Highlands Close
    SL9 0DR Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78431540001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SHAH, Bijal
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    Secrétaire
    24 Dorset Mews
    Finchley
    N3 2BN London
    British116421860001
    TIDSALL, David Peter Charles
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    50 Anglesey Avenue
    Cove
    GU14 8SQ Farnborough
    Hampshire
    British3854790001
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BASS, Neil Anthony
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    Administrateur
    31 Archery Fields
    RG29 1AE Odiham
    Hampshire
    EnglandBritish70199330002
    BEATON, Richard L'Estrange
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    Administrateur
    Prestbury Hall
    The Village
    SK10 4BN Prestbury
    Cheshire
    EnglandBritish97291590001
    BODHA, James Sanjay
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    Administrateur
    Rook How
    22 Elm Tree Road
    WA13 0NB Lymm
    Cheshire
    EnglandBritish93657140001
    COLL, Andrew
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish237260100001
    GIBSON, John Leonard
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    Administrateur
    Ivydene
    Delly End
    OX29 9XD Hailey
    Oxfordshire
    British104554430001
    HUMPHREY, Christopher John
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    Administrateur
    Well House
    School Lane, Northend
    BA1 7EP Bath
    Somerset
    United KingdomBritish32877720003
    HUNT, Simon Anthony
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    Administrateur
    Apt 31 21 Sheldon Square
    Paddington Central
    W2 6DS London
    British118771650001
    KINGSWOOD, Michael
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    Administrateur
    Holm Farm
    Catesby End Hellidon
    NN11 6GB Daventry
    Northamptonshire
    British123863990001
    MARRISON, Michael Anthony
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    Administrateur
    10 Armistead Way
    Cranage
    CW4 8FE Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish67938980003
    MCCANN, James
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    32 Carter Close
    SL4 3QX Windsor
    Berkshire
    British69923680001
    MEADEN, David John
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding
    Estate, Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish193740420001
    NOBLE, Ian Michael
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish199843940001
    ROWLEY, Stephen Paul, Mr.
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    Administrateur
    Hadleigh 16 Sandown Road
    KT10 9TU Esher
    Surrey
    United KingdomBritish93738770001
    SLOGGETT, David Raymond, Dr
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    Administrateur
    12 Mcnaughton Close
    GU14 0PX Farnborough
    Hampshire
    British34112730001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    TAIT, Ian
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    Administrateur
    Field House
    Evesham Road
    WR10 2QR Fladbury
    Worcestershire
    United KingdomBritish76976490001
    TYRRELL, Simon Robert Edgar
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    Administrateur
    Larks
    15 Burstead Close
    KT11 2NL Cobham
    Surrey
    EnglandBritish77284710002
    WENMAN, Nicholas Edward
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Three Gates 40a Guildown Road
    GU2 5EY Guildford
    Surrey
    British14373460003
    WOOTTON BEARD, Timothy
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Catkins
    Westhill Road North, South Wonston
    SO21 3HJ Winchester
    Hampshire
    British93274500001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NPS (UK5) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06526803
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    NPS (UK5) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of accession
    Créé le 27 févr. 2009
    Livré le 09 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transactions
    • 09 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 01 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 november 2006
    Créé le 15 févr. 2007
    Livré le 01 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 28 nov. 2006
    Livré le 30 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 9TH december 2002
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 02 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 02 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of deposit
    Créé le 18 déc. 2003
    Livré le 19 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Créé le 09 déc. 2002
    Livré le 13 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 10 mai 2002
    Livré le 24 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 24 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating security document
    Créé le 08 déc. 2000
    Livré le 21 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys debts and liabilities due owing or incurred by the company to any finance party under or in connection with any finance document (in each case whether alone or jointly or jointly or severally with any other person whether actually or contingently and whether as principal surety or otherwise)
    Brèves mentions
    The property as described in the schedule attached to the form 395 all other real property all book debts bank accounts investments uncalled capital and goodwill intellectual property plant and machinery insurances please refer to form 395 for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of amendment and restatement (for amending and restating a guarantee & debenture dated 6 october 1995)
    Créé le 09 avr. 1999
    Livré le 21 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 1998
    Livré le 10 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 04 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    NPS (UK5) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juin 2019Commencement of winding up
    02 oct. 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0